Buscador CIF Logo

Actos BORME Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar Sl

Actos BORME Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar Sl - B83643726

Tenemos registrados 40 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar Sl con CIF B83643726

🔙 Perfil de Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar Sl

23 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: MACCORMACK CALVIN WARREN. Nombramientos. Representan: HENDERSON DEREKALAN. Datos registrales. T 42880 , F 15, S 8, H M 327912, I/A 50 (14.03.23).

Nombramientos. Apoderado: COBREIRO RODRIGUEZ PABLO;ALONSO MONFORTE BORJA;CAMARA RODRIGUEZCRISTINA;GONZALEZ BARBA GONZALEZ GALLARZA BORJA. Datos registrales. T 42880 , F 15, S 8, H M 327912, I/A 51(15.03.23).

11 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GUILLEN BASTANTE JUAN IGNACIO;CISNEROS CANTIN REBECA. Datos registrales. T 42880 , F 14,S 8, H M 327912, I/A 49 ( 4.10.22).

06 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: HENDERSON DEREK ALAN. Datos registrales. T 42880 , F 13, S 8, H M 327912, I/A 48 (29.09.22).

07 de Junio de 2022
Cambio de domicilio social. C/ QUINTANADUEÑAS 6 - EDIFICIO C, PLANTA TERCERA (MADRID). Datos registrales. T 42880 ,F 13, S 8, H M 327912, I/A 47 (31.05.22).

23 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: HENDERSON DEREK ALAN. Nombramientos. Representan: MACCORMACK CALVINWARREN. Datos registrales. T 42880 , F 12, S 8, H M 327912, I/A 46 (16.03.22).

01 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ BARBA GONZALEZ GALLARZA BORJA. Datos registrales. T 42880 , F 11, S 8, H M327912, I/A 45 (25.01.22).

28 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MACCORMACK CALVIN WARREN. Datos registrales. T 32284 , F 225, S 8, H M 327912, I/A 44(21.12.21).

08 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: CRUZ TORRES RAFAEL;MENDEZ GOMEZ LARA. Datos registrales. T 32284 , F 225, S 8, H M327912, I/A 43 ( 1.09.21).

30 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Representan: SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO;CASTELLANO TORNERO CESAR. Adm. Mancom.:EOLICA DE MALAGA SL;SONDASOL SPAIN SL. Nombramientos. Adm. Unico: NORTHLAND POWER SPAIN HOLDINGS SL.Representan: HENDERSON DEREK ALAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradoresmancomunados a Administrador único. Cambio de domicilio social. PASEO DE RECOLETOS, 7-9. (MADRID). Datos registrales.T 32284 , F 225, S 8, H M 327912, I/A 42 (23.08.21).

23 de Marzo de 2021
Modificaciones estatutarias. Artículo 9 bis. Datos registrales. T 32284 , F 225, S 8, H M 327912, I/A 41 (15.03.21).

03 de Febrero de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: STADIUM WIND SL. Datos registrales. T 32284 , F 224, S 8, H M327912, I/A 40 (27.01.21).

14 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: CRUZ TORRES RAFAEL. Nombramientos. Representan: CASTELLANO TORNERO CESAR.Datos registrales. T 32284 , F 224, S 8, H M 327912, I/A 39 ( 7.08.18).

20 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: IRIS INVESTMENTS SUCURSAL EN ESPAÑA. Datos registrales. T 32284 , F 224, S 8, H M 327912,I/A 38 (12.12.17).

01 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: IRIS INVESTMENTS SUCURSAL EN ESPAÑA. Datos registrales. T 32284 , F 223, S 8, H M327912, I/A 37 (22.11.17).

08 de Septiembre de 2017
Declaración de unipersonalidad. Socio único: HELIA RENOVABLES FCR. Ceses/Dimisiones. Consejero: EDF EN IBERIASA;ROUHIER DENIS JEAN PIERRE;LOLIN SEKELJ ZORAN. Presidente: LOLIN SEKELJ ZORAN. Representan: BELLOY FREDERICMARIE ALBERT. SecreNoConsj: DE LA PEÑA DIEZ DE ULZURRUN LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: EOLICA DE MALAGASL;SONDASOL SPAIN SL. Representan: SANABRIA SMITH PEDRO ALEJANDRO;CRUZ TORRES RAFAEL. Modificacionesestatutarias. HA QUEDADO REFUNDIDO EL TEXTO INTEGRO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. Cambio de domicilio social. PASEO DELA CASTELLANA, NUMERO 91, PLANTA 11ª (MADRID). Cambio de objeto social. LA PROMOCION, GESTION, DISEÑO,CONSTRUCCION, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRODUCCION DE ENERGIA,ENTRE OTRAS, PERO SIN LIMITARSE A, ENERGIAS RENOVABLES. Datos registrales. T 32284 , F 218, S 8, H M 327912, I/A 35 (1.09.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON;FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL;MURUA PEREZISABEL;GONZALEZ SOLA EDUARDO. Apoderado: PANERO RIELO ROSA;MURUA PEREZ ISABEL;PEREZ ESTEBARANNOELIA;GONZALEZ SOLA EDUARDO;LOLIN SEKELJ ZORAN;IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON;FERNANDEZ DE SALAMANCADANIEL;IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON;FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL;GONZALEZ SOLA EDUARDO;FERNANDEZDE SALAMANCA DANIEL. Apo.Manc.: SERRE CEDRICK;LOLIN SEKELJ ZORAN;GONZALEZ SOLA EDUARDO. Apoderado:GONZALEZ SOLA EDUARDO;LOLIN SEKELJ ZORAN;EGUES WASSUM RICHARD. Apo.Man.Soli: IRISARRI ESCOLAR JOSERAMON. Apo.Manc.: GOMEZ GRANDE ELENA;LOLIN SEKELJ ZORAN;GONZALEZ SOLA EDUARDO. Apoderado: MURUA PEREZISABEL. Nombramientos. Apoderado: CRUZ TORRES RAFAEL;MENDEZ GOMEZ LARA. Datos registrales. T 32284 , F 222, S 8,H M 327912, I/A 36 ( 1.09.17).

05 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: BOUVIER LAURENCE MARTINE CHRISTIANE. Consejero: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON.Presidente: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON. Nombramientos. Representan: BELLOY FREDERIC MARIE ALBERT. Consejero:LOLIN SEKELJ ZORAN. Presidente: LOLIN SEKELJ ZORAN. Datos registrales. T 32284 , F 217, S 8, H M 327912, I/A 34 (26.05.17).

19 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32284 , F 217, S 8, H M 327912, I/A 33 ( 9.12.16).

30 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: MURUA PEREZ ISABEL. Datos registrales. T 32284 , F 216, S 8, H M 327912, I/A 32 (23.09.16).

18 de Febrero de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32284 , F 216, S 8, H M 327912, I/A 31 (10.02.16).

08 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32284 , F 216, S 8, H M 327912, I/A 30 (28.09.15).

17 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL;BOUVIER LAURENCE MARTINE CHRISTIANE.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 28º.MODIFICADO. Datos registrales. T 32284 , F 216, S 8, H M 327912, I/A 29 ( 9.03.15).

08 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON. Apo.Manc.: GOMEZ GRANDE ELENA;LOLIN SEKELJZORAN;GONZALEZ SOLA EDUARDO. Datos registrales. T 32284 , F 215, S 8, H M 327912, I/A 28 ( 1.08.14).

17 de Julio de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON;FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL. Datos registrales. T32284 , F 215, S 8, H M 327912, I/A 27 (10.07.14).

26 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26901 , F 10, S 8, H M 327912, I/A 26 (19.11.13).

20 de Noviembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: SERRE CEDRICK. Datos registrales. T 26901 , F 10, S 8, H M 327912, I/A 25 (12.11.13).

03 de Octubre de 2013
Ampliacion del objeto social. Proporcionar servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones olocales de terceros, bien sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Datos registrales. T 26901 , F 9, S 8, H M 327912, I/A24 (24.09.13).

12 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CROUZAT PHILIPPE BERNARD FRANCOIS. Nombramientos. Consejero: ROUHIER DENIS JEANPIERRE. Datos registrales. T 26901 , F 9, S 8, H M 327912, I/A 23 ( 5.06.13).

25 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26901 , F 9, S 8, H M 327912, I/A 22 (18.02.13).

09 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MITHOIS PASCAL ANDRE GEORGES. Secretario: DE LA PEÑA Y DIEZ DE ULZURRUN LUIS.Consejero: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON. Presidente: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON. Consejero: FERNANDEZ DESALAMANCA DANIEL;BOUVIER LAURENCE MARTINE CHRISTIANE;CROUZART PHILLIPPE BERNARD FRANCOIS.Nombramientos. Representan: BOUVIER LAURENCE MARTINE CHRISTIANE. SecreNoConsj: DE LA PEÑA DIEZ DE ULZURRUNLUIS. Consejero: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON. Presidente: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON. Consejero: FERNANDEZ DESALAMANCA DANIEL;BOUVIER LAURENCE MARTINE CHRISTIANE;CROUZAT PHILIPPE BERNARD FRANCOIS;SIIF ENERGIESIBERICA SA. Datos registrales. T 26901 , F 8, S 8, H M 327912, I/A 21 (28.09.12).

08 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26901 , F 7, S 8, H M 327912, I/A 20 (26.09.12).

27 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SOLA EDUARDO;LOLIN SEKELJ ZORAN;EGUES WASSUM RICHARD. Datosregistrales. T 26901 , F 5, S 8, H M 327912, I/A 19 (17.10.11).

22 de Enero de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: SERRE CEDRICK;LOLIN SEKELJ ZORAN;GONZALEZ SOLA EDUARDO. Datos registrales. T 26901, F 2, S 8, H M 327912, I/A 18 (12.01.10).

19 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apoderado: IRISARRI ESCOLAR JOSE RAMON;FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL;GONZALEZ SOLAEDUARDO;FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL. Datos registrales. T 18807 , F 114, S 8, H M 327912, I/A 17 ( 7.10.09).

05 de Agosto de 2009
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SOLA EDUARDO;LOLIN SEKELJ ZORAN;IRISARRI ESCOLAR JOSERAMON;FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIEL. Datos registrales. T 18807 , F 114, S 8, H M 327912, I/A 16 (22.07.09).

19 de Mayo de 2009
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18807 , F 114, S 8, H M 327912, I/A 15 ( 6.05.09).

15 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: PANERO RIELO ROSA;MURUA PEREZ ISABEL;PEREZ ESTEBARAN NOELIA. Datos registrales. T18807 , F 114, S 8, H M 327912, I/A 14 (31.03.09).

13 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINS PIMENTA CARLOS. Nombramientos. Consejero: CROUZART PHILLIPPE BERNARDFRANCOIS;MITHOIS PASCAL ANDRE GEORGES. Datos registrales. T 18807 , F 113, S 8, H M 327912, I/A 13 (31.03.09).

13 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: SERRE TEDDY CEDRICK. Datos registrales. T 18807 , F 113, S 8, H M 327912, I/A 12 (30.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información