Buscador CIF Logo

Actos BORME Francisco Gea Perona Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Francisco Gea Perona Sociedad Anonima

Actos BORME Francisco Gea Perona Sociedad Anonima - A30006456

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Francisco Gea Perona Sociedad Anonima con CIF A30006456

馃敊 Perfil de Francisco Gea Perona Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Francisco Gea Perona Sociedad Anonima

02 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTA ELENA GONZALEZ ARA脩A. Nombramientos. Consejero: ENRIQUE QUEVEDO GIL.Datos registrales. T 3196 , F 182, S 8, H MU 8733, I/A 94 (26.01.23).

Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 9潞 de los Estatutos sociales relativo a la transmisi贸n de acciones.- Datos registrales. T3196 , F 193, S 8, H MU 8733, I/A 95 (26.01.23).

Nombramientos. Auditor: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES S.A.P. Aud.C.Con.: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES S.A.P.Datos registrales. T 3196 , F 193, S 8, H MU 8733, I/A 96 (26.01.23).

12 de Abril de 2021
Otros conceptos: Se adiciona el art铆culo 4 bis, y se modifican los art铆culos 11 y 12 de los estatutos sociales.- Modifican la duraci贸ndel cargo siendo de 5 a帽os.- Cambio de objeto social. La compra, suscripci贸n, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales yextranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediaci贸n, con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichasparticipaciones. Datos registrales. T 3196 , F 181, S 8, H MU 8733, I/A 92 ( 5.04.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARO GONZALEZ VILLATE;JUAN FERNANDO PAREDES BATISTA;FEDERICOMOLDENHAUER ROMERO;FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Secretario: FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Presidente: JUANFERNANDO PAREDES BATISTA. Consejero: MANUEL GONZALEZ DE MIGUEL;MARTA ELENA GONZALEZ ARA脩A;MARIACRISTINA GONZALEZ SANCHEZ;ALVARO GONZALEZ FERNANDEZ LADREDA. Nombramientos. Consejero: JUAN FERNANDOPAREDES BATISTA. Presidente: JUAN FERNANDO PAREDES BATISTA. Consejero: FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Secretario:FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Consejero: FEDERICO MOLDENHAUER ROMERO;MANUEL GONZALEZ DE MIGUEL;ALVAROGONZALEZ FERNANDEZ LADREDA;MARTA ELENA GONZALEZ ARA脩A;JAVIER CHECA QUEVEDO. Datos registrales. T 3196 ,F 182, S 8, H MU 8733, I/A 93 ( 5.04.21).

P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.grupogeaperona.com. Datos registrales. T 3196 , F 182,S 8, H MU 8733, I/A 92 ( 5.04.21).

29 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Consejero: ALVARO GONZALEZ FERNANDEZ LADREDA. Datos registrales. T 3196 , F 180, S 8, H MU 8733, I/A91 (22.09.20).

01 de Junio de 2020
Cambio de domicilio social. CTRA DE SAN JAVIER, KM 24,3, TORRECIEGA Km (CARTAGENA). Datos registrales. T 3196 , F180, S 8, H MU 8733, I/A 90 (25.05.20).

23 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE JULIO GONZALEZ GONZALEZ. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero:IGNACIO BERNARDO LOPEZ GONZALEZ. Nombramientos. Consejero: MARTA ELENA GONZALEZ ARA脩A;MARIA CRISTINAGONZALEZ SANCHEZ. Auditor: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES S.A.P. Aud.C.Con.: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORESS.A.P. Datos registrales. T 3196 , F 180, S 8, H MU 8733, I/A 89 (16.12.19).

15 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE JULIO QUEVEDO GONZALEZ. Nombramientos. Consejero: JOSE JULIO GONZALEZGONZALEZ. Datos registrales. T 3196 , F 180, S 8, H MU 8733, I/A 88 ( 8.01.19).

16 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: ALVARO GONZALEZ VILLATE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVARO GONZALEZVILLATE;JOSE ANTONIO GOMEZ ABRIL;MARIO ROSIQUE TABUENCA. Nombramientos. Presidente: JUAN FERNANDOPAREDES BATISTA. Apo.Man.Soli: JUAN FERNANDO PAREDES BATISTA;MARIO ROSIQUE TABUENCA. Datos registrales. T3196 , F 178, S 8, H MU 8733, I/A 85 ( 5.07.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: JUAN FERNANDO PAREDES BATISTA;MARIO ROSIQUE TABUENCA. Datos registrales. T 3196 , F178, S 8, H MU 8733, I/A 87 ( 5.07.18).

03 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Nombramientos. Consejero: MANUEL GONZALEZ DEMIGUEL. Datos registrales. T 3196 , F 178, S 8, H MU 8733, I/A 86 (26.06.18).

19 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ISABEL DE TORRES MOLDENHAUER;FERNANDO MOLDENHAUER CARRILLO;FRANCISCOPROVENCIO RUBIO. Secretario: FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Nombramientos. Consejero: JUAN FERNANDO PAREDESBATISTA;FEDERICO MOLDENHAUER ROMERO;FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Secretario: FRANCISCO PROVENCIO RUBIO.Reelecciones. Consejero: ALVARO GONZALEZ VILLATE;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Presidente: ALVAROGONZALEZ VILLATE. Secretario: FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Datos registrales. T 3196 , F 178, S 8, H MU 8733, I/A 84(12.12.17).

18 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO MOLDENHAUER CARRILLO. Nombramientos. Consejero: FERNANDOMOLDENHAUER CARRILLO. Datos registrales. T 3196 , F 178, S 8, H MU 8733, I/A 83 (11.07.17).

01 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Auditor: ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP. Aud.C.Con.: ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP. Datosregistrales. T 3196 , F 178, S 8, H MU 8733, I/A 82 (24.11.16).

22 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVARO GONZALEZ VILLATE;JOSE ANTONIO GOMEZ ABRIL. Nombramientos. Apo.Man.Soli:ALVARO GONZALEZ VILLATE;JOSE ANTONIO GOMEZ ABRIL;MARIO ROSIQUE TABUENCA. Datos registrales. T 2831 , F 141,S 8, H MU 8733, I/A 81 (15.09.16).

07 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Consejero: FERNANDO MOLDENHAUER CARRILLO. Datos registrales. T 2831 , F 141, S 8, H MU 8733, I/A 80(31.08.16).

27 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANGEL RUBIO CASQUET. Datos registrales. T 2831 , F 140, S 8, H MU 8733, I/A 79 (19.07.16).

06 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MANUEL ALBERTOPEREZ GONZALEZ. Nombramientos. Secretario: FRANCISCO PROVENCIO RUBIO. Datos registrales. T 2831 , F 140, S 8, H MU8733, I/A 78 (30.05.16).

28 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: IGNACIO BERNARDO LOPEZ GONZALEZ;ISABEL DE TORRES MOLDENHAUER;JOSE JULIOGONZALEZ GONZALEZ. Nombramientos. Consejero: ISABEL DE TORRES MOLDENHAUER;IGNACIO BERNARDO LOPEZGONZALEZ;JOSE JULIO QUEVEDO GONZALEZ. Datos registrales. T 2831 , F 140, S 8, H MU 8733, I/A 77 (21.04.16).

05 de Agosto de 2014
Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: AYORA GEA TRANSPORTES PETROLIFEROS SA. Datos registrales. T 2831 , F140, S 8, H MU 8733, I/A 76 (29.07.14).

09 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2831 , F 139, S 8, H MU 8733,I/A 75 (29.11.13).

21 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARO GONZALEZ VILLATE;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;PEDRO LUISMOLDENHAUER FERNANDEZ;LORETO MOLDENHAUER GOMEZ. Presidente: ALVARO GONZALEZ VILLATE. Con.Delegado:ALVARO GONZALEZ VILLATE. Secretario: MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Nombramientos. Consejero: ALVAROGONZALEZ VILLATE;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;ANGEL RUBIO CASQUET;FRANCISCO PROVENCIO RUBIO.Presidente: ALVARO GONZALEZ VILLATE. Secretario: MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Datos registrales. T 2831 , F 139,S 8, H MU 8733, I/A 74 (14.11.13).

05 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Con.Delegado: ALVARO GONZALEZ VILLATE. Datos registrales. T 2831 , F 138, S 8, H MU 8733, I/A 72(24.10.12).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVARO GONZALEZ VILLATE;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;JOSE ANTONIO GOMEZABRIL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVARO GONZALEZ VILLATE;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;JOSE ANTONIOGOMEZ ABRIL. Datos registrales. T 2831 , F 138, S 8, H MU 8733, I/A 73 (24.10.12).

25 de Octubre de 2012
Nombramientos. Auditor: VIAUDIT SLP. Aud.C.Con.: VIAUDIT SLP. Datos registrales. T 2831 , F 137, S 8, H MU 8733, I/A 70(16.10.12).

Otros conceptos: MODIFICAN LOS ARTICULOS 1, 11, PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 12 Y ARTICULO 16 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2831 , F 137, S 8, H MU 8733, I/A 71 (17.10.12).

30 de Enero de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVARO GONZALEZ VILLATE;JOSE ANTONIO GOMEZ ABRIL. Nombramientos. Apo.Man.Soli:ALVARO GONZALEZ VILLATE;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;JOSE ANTONIO GOMEZ ABRIL. Datos registrales. T 2831, F 136, S 8, H MU 8733, I/A 69 (19.01.12).

17 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FEDERICO MOLDENHAUER DIAZ. Nombramientos. Consejero: ISABEL DE TORRESMOLDENHAUER. Datos registrales. T 2831 , F 136, S 8, H MU 8733, I/A 68 ( 8.11.11).

26 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: JOSE BASTIDA EGEA. Datos registrales. T 2831 , F 136, S 8, H MU 8733, I/A 67 (17.10.11).

31 de Agosto de 2011
Nombramientos. Auditor: VIAUDIT SLP. Aud.C.Con.: VIAUDIT SLP. Datos registrales. T 2478 , F 86, S 8, H MU 8733, I/A 64(22.08.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: IGNACIO BERNARDO LOPEZ GONZALEZ;IGNACIO GONZALEZ MONTORO. Nombramientos.Consejero: IGNACIO BERNARDO LOPEZ GONZALEZ;JOSE JULIO GONZALEZ GONZALEZ. Datos registrales. T 2478 , F 86, S 8,H MU 8733, I/A 65 (22.08.11).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSE MARIA CASANOVA SANCHEZ. Datos registrales. T 2831 , F 136, S 8, H MU 8733, I/A 66(22.08.11).

23 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: VIAUDIT SLP. Aud.C.Con.: VIAUDIT SLP. Datos registrales. T 2478 , F 86, S 8, H MU 8733, I/A 63(15.07.10).

21 de Enero de 2010
Reelecciones. Aud.C.Con.: VIAUDIT SLP. Auditor: VIAUDIT SLP. Datos registrales. T 2478 , F 86, S 8, H MU 8733, I/A 61(12.01.10).

Reelecciones. Aud.C.Con.: VIAUDIT SLP. Auditor: VIAUDIT SLP. Datos registrales. T 2478 , F 86, S 8, H MU 8733, I/A 62(12.01.10).

18 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARO GONZALEZ VILLATE;ISABEL DE TORRES MOLDENHAUER;FEDERICO MOLDENHAUERCARRILLO;JOSE PROVENCIO RUBIO. Presidente: ALVARO GONZALEZ VILLATE. Secretario: FEDERICO MOLDENHAUERCARRILLO. Consejero: MANUEL GONZALEZ DE MIGUEL;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Nombramientos. Consejero:MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ;ALVARO GONZALEZ VILLATE;FEDERICOMOLDENHAUER DIAZ;PEDRO LUIS MOLDENHAUER FERNANDEZ;LORETO MOLDENHAUER GOMEZ. Presidente: ALVAROGONZALEZ VILLATE. Secretario: MANUEL ALBERTO PEREZ GONZALEZ. Datos registrales. T 2478 , F 85, S 8, H MU 8733, I/A 60( 9.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n