Actos BORME de Free Technologies Excom Sl
20 de Noviembre de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 41220 , F 182, S 8, H M 281424, I/A 32 (13.11.23).
22 de Junio de 2022Modificaciones estatutarias. INCORPORACION DEL ARTICULO 12BIS.- PRENDA DE LAS PARTICIPACIONES DE LASOCIEDAD. Datos registrales. T 41220 , F 182, S 8, H M 281424, I/A 31 (15.06.22).
13 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ABENZA RUANO LUIS MANUEL. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ SAAVEDRAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41220 , F 182, S 8, H M 281424, I/A 30 ( 6.04.22).
16 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: MORENO CASTANY FRANCISCO ASIS. Datos registrales. T 41220 , F 182, S 8, H M 281424, I/A 29 (9.02.22).
23 de Noviembre de 2021Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 27 el cese como consejero de DIAZ ANDREU GARCIA BERNARDINO. Datosregistrales. T 16523 , F 222, S 8, H M 281424, I/A 27 ( 8.02.21).
17 de Febrero de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MEGAVISTA ONLINE SL. IXIME NETLAN SL. RIOTELECOMM SL. Datosregistrales. T 16523 , F 223, S 8, H M 281424, I/A 28 (10.02.21).
15 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ ANDREU GARCIA BERNARDINO. Presidente: DIAZ ANDREU GARCIA BERNARDINO.Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ ATELA FELIPE. Datos registrales. T 16523 , F 222, S 8, H M 281424, I/A 27 ( 8.02.21).
19 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON;SANTANA GARCIA-FUSTER ALEJANDRO;BLANCOMORILLO MANUEL. Consejero: AGURRUZA FATOSME JAIME;ALVAREZ ARIAS DEOTINO. Presidente: ABENZA RUANO LUISMANUEL. Consejero: QNEX BARCODE GESTION SL;FIDES CAPITAL SL;NEWTELCO COMEX SBC SL. Nombramientos.Consejero: DIAZ ANDREU GARCIA BERNARDINO;DE PABLO CAJAL JOSE RAMON;QUINN BERNARDO;FERNANDEZ ATELAFELIPE. Presidente: DIAZ ANDREU GARCIA BERNARDINO. Datos registrales. T 16523 , F 221, S 8, H M 281424, I/A 26 (12.01.21).
03 de Noviembre de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EXCOM TELECOM GROUP SL. Datos registrales. T 16523 , F 221, S 8, H M281424, I/A 25 (26.10.20).
17 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCO MORILLO MANUEL. Nombramientos. Representan: BLANCO MORILLO MANUEL.Consejero: NEWTELCO COMEX SBC SL. Datos registrales. T 16523 , F 221, S 8, H M 281424, I/A 24 (10.06.20).
20 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: MORENO CASTANY FRANCISCO ASIS. Datos registrales. T 16523 , F 219, S 8, H M 281424, I/A 23(13.12.19).
14 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. -. Refundici贸n estatutos.. Datos registrales. T 16523 , F 214, S 8, H M 281424, I/A 22 ( 5.11.18).
19 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN MORENO ANGEL FRANCISCO. Datos registrales. T 16523 , F 214, S 8, H M 281424, I/A 21(12.03.18).
08 de Enero de 2018Modificaciones estatutarias. 1-27. Nueva redacci贸n de los estatutos sociales.. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:IPOK TELECOM SL. CENTRAL PHONE TECNOLOGIA SL. WIFI WAYS SL. Datos registrales. T 16523 , F 207, S 8, H M 281424, I/A20 (29.12.17).
28 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: COLL HERNANDEZ JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 16523 , F 207, S 8, H M 281424, I/A 19(19.12.17).
07 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: COLL HERNANDEZ JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 16523 , F 203, S 8, H M 281424, I/A 17(28.07.17).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.824,00 Euros. Resultante Suscrito: 124.469,00 Euros. Datos registrales. T 16523 , F 206, S 8, HM 281424, I/A 18 (31.07.17).
17 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.195,00 Euros. Resultante Suscrito: 120.645,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de
13 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GALIANA AGURRUZA FRANCISCO JAVIER;DURAN DEL CAMPO JAIME;GALIANA AGURRUZAJAIME JESUS. Secretario: DURAN DEL CAMPO JAIME. Vicepresid.: ABENZA SANCHEZ LUIS MANUEL. Nombramientos.Representan: SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON. Consejero: QNEX BARCODE GESTION SL;FIDES CAPITAL SL. SecreNoConsj:BLANCO MORILLO CARLOS. Consejero: BLANCO MORILLO MANUEL. Representan: SANTANA GARCIA-FUSTER ALEJANDRO.Datos registrales. T 16523 , F 200, S 8, H M 281424, I/A 15 ( 3.01.17).
03 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 110.450,00 Euros. Datos registrales. T 16523 , F 200, S 8, HM 281424, I/A 14 (25.02.16).
16 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABENZA SANCHEZ LUIS MANUEL. Nombramientos. Consejero: ABENZA RUANO LUISMANUEL;ABENZA SANCHEZ LUIS MANUEL;DURAN DEL CAMPO JAIME;AGURRUZA FATOSME JAIME;GALIANA AGURRUZAFRANCISCO JAVIER;GALIANA AGURRUZA JAIME JESUS;ALVAREZ ARIAS DEOTINO. Presidente: ABENZA RUANO LUISMANUEL. Vicepresid.: ABENZA SANCHEZ LUIS MANUEL. Secretario: DURAN DEL CAMPO JAIME. Con.Delegado: ABENZASANCHEZ LUIS MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Cambio de objeto social. LA ACTUACION COMO OPERADOR DE COMUNICACIONES MOVILES, FIJAS Y DEREDES. Datos registrales. T 16523 , F 17, S 8, H M 281424, I/A 13 ( 5.02.15).
11 de Junio de 2013Cambio de domicilio social. AVDA DE VALDELAPARRA 27 - PLANTA 2, OFICINA 4 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 16523, F 16, S 8, H M 281424, I/A 12 ( 4.06.13).
31 de Mayo de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.650,00 Euros. Resultante Suscrito: 101.950,00 Euros. Datos registrales. T 16523 , F 16, S 8, H M281424, I/A 11 (24.05.13).
18 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: DURAN DEL CAMPO JAIME. Datos registrales. T 16523 , F 15, S 8, H M 281424, I/A 9 ( 4.02.10).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.290,00 Euros. Resultante Suscrito: 94.300,00 Euros. Datos registrales. T 16523 , F 16, S 8, H M281424, I/A 10 ( 5.02.10).
17 de Junio de 2009Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 37-39 3 - OFICINA 4 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 16523 , F 14, S8, H M 281424, I/A 8 ( 2.06.09).