Actos BORME de Freigel Foodsolutions SA
24 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: BOSCH SERCH CARLOS;COLL BATET JOSE MARIA;GUERRERO MONGE ANTONIA MARIA. Datosregistrales. T 305 , F 207, S 8, H ZA 7501, I/A 116 (17.07.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: BOSCH SERCH CARLOS;COLL BATET JOSE MARIA;CERVERA SERRANO JORDI;VALL MANETJORDI;ARANAZ DELBLANCH LOURDES;BARCELO CASTILLO DAVID;HERRERO TEJEDOR JOSE ALFONSO;SELLARES PUJOLROGER;PEREZ ESTEVE UBALDO. Datos registrales. T 305 , F 207, S 8, H ZA 7501, I/A 117 (17.07.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: BOSCH SERCH CARLES;GARCIA ALONSO FRANCISCO;ARANAZ DELBLANCH LOURDES;BARCELOCASTILLO DAVID;VALL MALET JORDI;SELLARES PUJOL ROGER;HERRERO TEJEDOR JOSE ALFONSO. Datos registrales. T305 , F 207, S 8, H ZA 7501, I/A 118 (17.07.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOSCH SERCH CARLES;GARCIA ALONSO FRANCISCO;GUERRERO MONGE ANTONIAMARIA;HERNANDEZ MATELLAN BORIS. Datos registrales. T 305 , F 208, S 8, H ZA 7501, I/A 119 (17.07.23).
06 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SALA COLL DAVID. Nombramientos. Adm. Unico: FASO SIGLO VEINTIUNO SL. Otrosconceptos: Se designa a don DAVID SALA COLL, NIF n煤mero 46.228.483-R, como representante persona f铆sica del administrador煤nico nombrado, la mercantil "FASO SIGLO VEINTIUNO SL". Datos registrales. T 305 , F 207, S 8, H ZA 7501, I/A 115 (23.02.23).
24 de Octubre de 2022Revocaciones. Auditor: AUDINFORM SLP. Datos registrales. T 269 , F 197, S 8, H ZA 7501, I/A 113 (14.10.22).
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 269 , F 197, S 8, H ZA 7501, I/A 114 (14.10.22).
04 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: AUDINFORM SLP. Datos registrales. T 269 , F 197, S 8, H ZA 7501, I/A 112 (23.02.21).
03 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: BUEDO PARRA RICARDO. Datos registrales. T 269 , F 197, S 8, H ZA 7501, I/A 111 (27.07.20).
19 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SALA COLL XAVIER;SALA COLL DAVID. Nombramientos. Adm. Unico: SALA COLL DAVID.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Se modifican los art铆culos15, 27 y la Disposici贸n Adicional tras la modificaci贸n de la estructura del 贸rgano de administraci贸n. Datos registrales. T 269 , F 196, S8, H ZA 7501, I/A 110 (10.03.20).
10 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSA RODRIGUEZ MONICA DEL CASTILLO. Datos registrales. T 269 , F 196, S 8, H ZA 7501, I/A108 (24.02.17).
26 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: TALAMAS JOFRESA RAMON. Apo.Sol.: TALAMAS JOFRESA RAMON. Apo.Manc.: VALL MALETJORDI;BOSCH SERCH CARLOS. Datos registrales. T 269 , F 195, S 8, H ZA 7501, I/A 106 (12.01.17).
13 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: COLL BATET JOSE MARIA;TALAMAS JOFRESA RAMON;TORRES PEREZ RAUL;PEREZ ESTEVEZUBALDO;VALL MALET JORDI;BOSCH SERCH CARLOS. Apo.Manc.: COLL BATET JOSE MARIA;TALAMAS JOFRESARAMON;GUERRERO MONGE MARIA ANTONIA;PEREZ ESTEVEZ UBALDO;BUEDO PARRA RICARDO. Datos registrales. T 269 ,F 195, S 8, H ZA 7501, I/A 105 ( 5.10.16).
05 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: TALAMAS JOFRESA RAMON;BOSCH SERCH CARLOS;COLL BATET JOSE MARIA;GUERREROMONGE ANTONIA MARIA. Datos registrales. T 269 , F 194, S 8, H ZA 7501, I/A 103 (27.07.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: TALAMAS JOFRESA RAMON;BOSCH SERCH CARLOS;COLL BATET JOSE MARIA;CERVERASERRANO JORDI;BUEDO PARRA RICARDO;VALL MANET JORDI;ARANAZ DELBLANCH LOURDES;BARCELO CASTILLODAVID;HERRERO TEJEDOR JOSE ALFONSO;SELLARES PUJOL ROGER;TORRES PEREZ RAUL;PEREZ ESTEVE UBALDO.Datos registrales. T 269 , F 195, S 8, H ZA 7501, I/A 104 (27.07.16).
25 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: AUDINFORM SLP. Datos registrales. T 269 , F 136, S 8, H ZA 7501, I/A 101 (16.03.15).
14 de Agosto de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA VALCABADO S/N(ROALES). Datos registrales. T 269 , F 136, S 8, H ZA 7501, I/A 100 (31.07.14).