Actos BORME de Frigicoll Valencia Sa
05 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 224, S 8, H V46649, I/A 43 (28.11.23).
10 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: WIWOK23 SL. Nombramientos. Adm. Solid.: ALVAREZ LOPEZ JUAN BAUTISTA. Datosregistrales. T 5436, L 2743, F 224, S 8, H V 46649, I/A 43 ( 3.08.23).
27 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANTOS MATA JOSE ANTONIO;SABRIA PITARCH JOAN;RIGOL COLL JUAN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ALVAREZ LOPEZ JUAN BAUTISTA;RIGOL COLL JUAN;SANTOS MATA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5436,L 2743, F 222, S 8, H V 46649, I/A 41 (21.07.23).
08 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VILA MESTRE ALEJANDRO;SABRIA PITARCH JOAN. Nombramientos. Adm. Solid.: SABRIAPITARCH JUAN;WIWOK23 SL. Otros conceptos: Se nombra como persona f铆sica representante del nuevo administrador solidarionombrado, la mercantil "WIWOK23, S.L.", al administrador 煤nico de esta 煤ltima, Don Juan Rigol Coll, con DNI.NIF. 47.646161M.-Datos registrales. T 5436, L 2743, F 222, S 8, H V 46649, I/A 40 (27.04.23).
28 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILA MESTRE ALEJANDRO. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 222, S 8, H V 46649, I/A 39(21.03.23).
11 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 222, S 8, H V46649, I/A 38 ( 4.10.22).
29 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S 8, H V46649, I/A 37 (17.09.21).
23 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S 8, H V46649, I/A 36 (16.11.20).
23 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOZALBO SORO EDUARDO JOSE MARIA. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S 8, H V46649, I/A 35 (16.07.18).
25 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: CERRATO RAMIREZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S 8, H V 46649, I/A34 (18.04.18).
03 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERRATO RAMIREZ ANTONIO JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: SABRIA PITARCHJOAN;VILA MESTRE ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoressolidarios. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S 8, H V 46649, I/A 33 (23.03.18).
12 de Febrero de 2018Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 27潞.-El cargo de administrador es gratuito.". Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S8, H V 46649, I/A 32 ( 5.02.18).
25 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 221, S 8, H V46649, I/A 31 (18.10.17).
31 de Julio de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FRIGICOLL SA. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 220, S 8, H V 46649, I/A 30(24.07.17).
23 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: REY CARDOS ERNESTO. Consejero: RIGOL JEREZ SALVADOR;CERRATO RAMIREZ ANTONIOJOSE;GOZALBO SORO EDUARDO;VILA MESTRE ALEJANDRO. Presidente: RIGOL JEREZ SALVADOR. Vicepresid.: CERRATORAMIREZ ANTONIO JOSE. Con.Delegado: GOZALBO SORO EDUARDO. Nombramientos. Adm. Unico: CERRATO RAMIREZANTONIO JOSE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Alobjeto de adaptar los estatutos sociales al nuevo sistema de administraci贸n se modifican los art铆culos 3, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 23 a29 y 31 de los estatutos sociales de la Sociedad Queda asimismo, modificado el sistema de retribuci贸n del mismo, por el art铆culo 27.Datos registrales. T 5436, L 2743, F 218, S 8, H V 46649, I/A 27 (16.01.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: SANTOS MATA JOSE ANTONIO. Apoderado: CERRATO RAMIREZ ANTONIO JOSE. Datos registrales.T 5436, L 2743, F 219, S 8, H V 46649, I/A 28 (16.01.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIGOL COLL JUAN;SABRIA PITARCH JOAN;VILA MESTRE ALEJANDRO;CERRATO RAMIREZANTONIO JOSE;GOZALBO SORO EDUARDO JOSE MARIA;SANTOS MATA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5436, L 2743, F219, S 8, H V 46649, I/A 29 (16.01.17).
12 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 218, S 8, H V46649, I/A 26 ( 4.11.14).
03 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ NOGUES FRANCISCO. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 211, S 8, H V 46649, I/A 25(24.02.14).
27 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: REVERT AHUMADA JORGE. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 211, S 8, H V 46649, I/A 24(20.01.14).
13 de Agosto de 2013Sucursal. EN ADEMUZ. Apertura de sucursal. Comienzo de operaciones: 22.07.13. Objeto social: La Sucursal tendr谩encomendadas las siguientes actividades: La adquisici贸n, enajenaci贸n, administraci贸n, gesti贸n, reparaci贸n y mantenimiento de todotipo de autom贸viles, inclusive autobuses, autocares y dem谩s veh铆culos pesados, y en general cuantos actos hagan referencia a la flotade veh铆culos de l. Domicilio: C/ MESON 49 (ADEMUZ). Nombramientos. R.L.C.Perma.: GOZALBO SORO EDUARDO. Datosregistrales. T 5436, L 2743, F 209, S 8, H V 46649, I/A 23 ( 6.08.13).
16 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: REVERT AHUMADA JORGE. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 209, S 8, H V 46649, I/A 21 (9.04.13).
09 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: LOZANO CARACENA MANUEL. Datos registrales. T 5436, L 2743, F 209, S 8, H V 46649, I/A 20 (2.04.13).