Actos BORME de Frigorificos Marbamar Sa
05 de Abril de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 34.377,20 Euros. Resultante Suscrito: 137.508,80 Euros. Datos registrales. T 4282 , F153, S 8, H A 14984, I/A 24 (27.03.23).
12 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: KRESTON IBERAUDIT APM SL. Datos registrales. T 4282 , F 153, S 8, H A 14984, I/A 23 (30.11.22).
09 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GANDOLFO MONICA. Datos registrales. T 4282 , F 153, S 8, H A 14984, I/A 22(31.08.22).
26 de Abril de 2021Cambio de objeto social. La explotaci贸n de frigor铆ficos, cuyos servicios podr谩n realizarse directamente o arrendarse a terceros. Laprecisi贸n del contenido de dicha explotaci贸n conlleva la comercializaci贸n, refrigeraci贸n, conservaci贸n, producci贸n, distribuci贸n yenvasado de toda clase de productos depositados en tales c谩mar. Datos registrales. T 4282 , F 153, S 8, H A 14984, I/A 21(16.04.21).
21 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: KRESTON IBERAUDIT APM SL. Datos registrales. T 3734 , F 25, S 8, H A 14984, I/A 20 (11.10.19).
18 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ QUILES FRANCISCA. Datos registrales. T 3734 , F 25, S 8, H A 14984, I/A 19 (10.01.19).
17 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ QUILES GUILLERMO. Presidente: MARTINEZ QUILES GUILLERMO. Consejero:MARTINEZ QUILES FRANCISCA. Secretario: MARTINEZ QUILES FRANCISCA. Consejero: GOMEZ CALDUCH JOSE LUIS.Nombramientos. Adm. Unico: GOMEZ MARTINEZ RAUL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Modificados la totalidad de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 3734 , F 23, S 8, H A14984, I/A 18 ( 9.01.19).
24 de Enero de 2017Revocaciones. Auditor: MENASALVAS FERNANDEZ CHECA CAROLINA. Nombramientos. Auditor: IBERAUDIT KRESTON APMSL. Datos registrales. T 3734 , F 23, S 8, H A 14984, I/A 17 (16.01.17).
19 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: MENASALVAS FERNANDEZ CHECA CAROLINA. Datos registrales. T 3734 , F 23, S 8, H A 14984, I/A16 (11.01.16).
20 de Enero de 2015Reelecciones. Consejero: MARTINEZ QUILES GUILLERMO. Presidente: MARTINEZ QUILES GUILLERMO. Consejero: MARTINEZQUILES FRANCISCA. Secretario: MARTINEZ QUILES FRANCISCA. Consejero: GOMEZ CALDUCH JOSE LUIS. Datos registrales.T 3734 , F 23, S 8, H A 14984, I/A 15 (12.01.15).
17 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MARTINEZ RAUL. Datos registrales. T 1474 , F 48, S 8, H A 14984, I/A 14 ( 9.12.13).
08 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: ESPACIO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1474 , F 48, S 8, H A 14984, I/A 13 ( 1.10.13).
19 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: ESPACIO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1474 , F 48, S 8, H A 14984, I/A 12 ( 7.01.11).
03 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ IRENE;MARTINEZ QUILES FRANCISCA;MARTINEZ QUILESGUILLERMO;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;MARTINEZ LOPEZ LORENZO PASCUAL;CARDONA IVARS PATRICIA. Presidente:MARTINEZ LOPEZ IRENE. Secretario: MARTINEZ QUILES FRANCISCA. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ QUILESGUILLERMO. Presidente: MARTINEZ QUILES GUILLERMO. Consejero: MARTINEZ QUILES FRANCISCA. Secretario: MARTINEZQUILES FRANCISCA. Consejero: GOMEZ CALDUCH JOSE LUIS. Datos registrales. T 1474 , F 48, S 8, H A 14984, I/A 11(25.05.09).