Actos BORME de Friocargo Herbatra Sl
04 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Auditor: GRACIA HERREIZ FRANCISCO JOSE. Aud.Supl.: NIETO AVELLANED JAVIER. Nombramientos.Auditor: AUDITORIA CONSULTORIA GBS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3200 , F 43, S 8, H Z 35558, I/A 13(29.03.23).
05 de Abril de 2022Nombramientos. Auditor: GRACIA HERREIZ FRANCISCO JOSE. Aud.Supl.: NIETO AVELLANED JAVIER. Datos registrales. T3200 , F 42, S 8, H Z 35558, I/A 12 (30.03.22).
14 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: DIEZ PINILLA ALEJANDRO. Datos registrales. T 3200 , F 42, S 8, H Z 35558, I/A 11 (10.01.22).
06 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: DIEZ PINILLA ALEJANDRO. Datos registrales. T 3200 , F 42, S 8, H Z 35558, I/A 10 (30.03.20).
27 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: DIEZ PINILLA ALEJANDRO. Datos registrales. T 3200 , F 41, S 8, H Z 35558, I/A 9 (20.01.20).
23 de Febrero de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO BAILON 2001 SL. Datos registrales. T 3200 , F 41, S 8, H Z 35558, I/A 8(19.02.18).
29 de Septiembre de 2015Cambio de objeto social. El transporte p煤blico discrecional de mercanc铆as por carretera, de 谩mbito nacional e internacional.Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes. La gesti贸n y explotaci贸n de gasolineras y estaciones de servicio.Comercio al por menor de productos de alimentaci贸n y para el manteni. Datos registrales. T 3200 , F 41, S 8, H Z 35558, I/A 7(21.09.15).
10 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: DE MIGUEL LEDESMA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3200 , F 41, S 8, H Z 35558, I/A 6(29.09.11).
18 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: BAILON ROY ALEJANDRA. Datos registrales. T 3200 , F 40, S 8, H Z 35558, I/A 5 ( 5.08.11).