Actos BORME de Fritta Sl
17 de Noviembre de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ESMALGLASS SA. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 31, S 8, HCS 12213, I/A 119 (10.11.23).
21 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE;SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE;SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Datos registrales.T 1678, L 1239, F 114, S 8, H CS 12213, I/A 111 (11.08.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: AGRAMUNT LERMA JOSE VICENTE;RIBERA LLORACH JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1678, L1239, F 115, S 8, H CS 12213, I/A 112 (11.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: VACAS CORREDOR CARLOS JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: VACAS CORREDOR CARLOSJAVIER. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 26, S 8, H CS 12213, I/A 113 (11.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: PEINADO GARCIA ALEJANDRO;NIETO RANERO JOSE MANUEL;NIETO RANERO JOSEMANUEL;NIETO RANERO JOSE MANUEL;GARZO CALATAYUD ROSANNA;GARZO CALATAYUD ROSANNA. Nombramientos.Apo.Sol.: PEINADO GARCIA ALEJANDRO;NIETO RANERO JOSE MANUEL;GARZO CALATAYUD ROSANNA. Datos registrales. T1907, L 1467, F 27, S 8, H CS 12213, I/A 114 (11.08.23).
Revocaciones. Apoderado: CARRION DORADO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apo.Sol.: BOSCA WATTS WENDY;CABEDOLANUZA MARIA;CASTELLET GOMEZ RAUL;CARRION DORADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 28, S 8, HCS 12213, I/A 115 (11.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE.Datos registrales. T 1907, L 1467, F 30, S 8, H CS 12213, I/A 116 (11.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: FALOMIR MARISTANY JACOBO. Nombramientos. Apo.Sol.: FALOMIR MARISTANY JACOBO. Datosregistrales. T 1907, L 1467, F 30, S 8, H CS 12213, I/A 117 (11.08.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: NACHER SILVESTRE FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1907, L 1467, F 31, S 8, H CS 12213,I/A 118 (11.08.23).
10 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: TORTAJADA GIRBES JOSE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 114, S 8, H CS 12213, I/A 110 (3.05.23).
23 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: NIETO RANERO JOSE MANUEL;GARZO CALATAYUD ROSANNA. Datos registrales. T 1678, L 1239,F 113, S 8, H CS 12213, I/A 109 (16.11.22).
06 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. INCLUSION ART. 8 BIS. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 113, S 8, H CS 12213, I/A 107(28.09.22).
02 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: PEINADO GARCIA ALEJANDRO;NIETO RANERO JOSE MANUEL;GARZO CALATAYUDROSANNA;SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 113, S 8, H CS 12213, I/A 106(25.08.22).
18 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE;BLASCO FUENTES ANTONIO;BAGAN VARGAS VICENTEANTONIO. Presidente: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. SecreNoConsj: ECHENIQUE SANJURJO MANUEL. VsecrNoConsj:TORRECILLAS POWER ELIZABETH. Nombramientos. Adm. Unico: NITRUR DE BOR SL. Otros conceptos: Cambio del Organode Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 112, S 8, H CS 12213, I/A105 (10.08.22).
11 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 112, S 8, H CS12213, I/A 104 ( 3.11.21).
20 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: TORTAJADA GIRBES JOSE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 111, S 8, H CS 12213, I/A 102(13.10.21).
Nombramientos. Apoderado: CARRION DORADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 112, S 8, H CS 12213, I/A103 (13.10.21).
14 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Presidente: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T1678, L 1239, F 111, S 8, H CS 12213, I/A 101 ( 7.07.21).
06 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 111, S 8, H CS12213, I/A 100 (29.10.20).
27 de Agosto de 2020Reelecciones. Consejero: BLASCO FUENTES ANTONIO;BAGAN VARGAS VICENTE ANTONIO. Datos registrales. T 1678, L1239, F 111, S 8, H CS 12213, I/A 99 (20.08.20).
02 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 111, S 8, H CS12213, I/A 98 (25.06.20).
16 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: NIETO RANERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 110, S 8, H CS 12213, I/A 96 (6.05.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: ROS MONTESINOS JOSE-VICENTE. Nombramientos. Apo.Sol.: VACAS CORREDOR CARLOS JAVIER.Datos registrales. T 1678, L 1239, F 110, S 8, H CS 12213, I/A 97 ( 6.05.19).
11 de Septiembre de 2018Modificaciones estatutarias. Añadido artículo 9 bis a los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 110, S 8, H CS12213, I/A 95 (28.08.18).
13 de Abril de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE;ROS MONTESINOS JOSE VICENTE;FALOMIR MARISTANYJACOBO;PEREA SERRAN ALFONSO;ARCHILES PROHIAS JOSEP. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 107, S 8, H CS 12213, I/A89 ( 5.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-PERAL SANCHEZ VICENTE-JOSE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 108, S 8, H CS12213, I/A 90 ( 5.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: BAGAN VARGAS VICENTE ANTONIO;BLASCO FUENTES ANTONIO. Datos registrales. T 1678, L1239, F 108, S 8, H CS 12213, I/A 91 ( 5.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROS MONTESINOS JOSE-VICENTE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 109, S 8, H CS 12213, I/A 92( 5.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: FALOMIR MARISTANY JACOBO. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 109, S 8, H CS 12213, I/A 93 (5.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 109, S 8, H CS 12213, I/A 94 (5.04.18).
20 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VARA VAREA MANUEL. VsecrNoConsj: PIRIZ GOMEZ BEATRIZ. Nombramientos.SecreNoConsj: ECHENIQUE SANJURJO MANUEL. VsecrNoConsj: TORRECILLAS POWER ELIZABETH. Datos registrales. T 1678,L 1239, F 107, S 8, H CS 12213, I/A 88 ( 7.12.17).
23 de Febrero de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 107, S 8, H CS12213, I/A 87 (10.02.17).
07 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 107, S 8,H CS 12213, I/A 85 (31.01.17).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 107, S 8, H CS 12213, I/A 86 (31.01.17).
15 de Noviembre de 2016Reelecciones. Consejero: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Presidente: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T1678, L 1239, F 106, S 8, H CS 12213, I/A 84 ( 7.11.16).
03 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASAS TRAVER ROSER;PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Apo.Sol.: FALOMIR MARISTANYJACOBO. Apo.Man.Soli: PEREA SERRAN ALFONSO;ROS MONTESINOS JOSE VICENTE. Datos registrales. T 1678, L 1239, F106, S 8, H CS 12213, I/A 83 (26.07.16).
23 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ARCHILES PROHIAS JOSEP. Datos registrales. T 1678, L 1239, F 106, S 8, H CS 12213, I/A 82(16.06.16).
08 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE;ROS MONTESINOS JOSE VICENTE;FALOMIR MARISTANYJACOBO;PEREA SERRAN ALFONSO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 211, S 8, H CS 12213, I/A 81 (29.05.15).
28 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: NAZCA DIRECTORSHIPS I S.L. Presidente: NAZCA DIRECTORSHIPS I S.L. Consejero: NAZCADIRECTORSHIPS II S.L.;SANGRO GOMEZ-ACEBO PEDRO. Secretario: SANGRO GOMEZ-ACEBO PEDRO. Nombramientos.Consejero: BLASCO FUENTES ANTONIO;BAGAN VARGAS VICENTE ANTONIO. SecreNoConsj: VARA VAREA MANUEL.VsecrNoConsj: PIRIZ GOMEZ BEATRIZ. Presidente: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Modificaciones estatutarias. Modificadoapartado 11 del articulo 16. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 210, S 8, H CS 12213, I/A 80 (21.04.15).
25 de Febrero de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: FRANCH PERSONAT SANTIAGO;CADROY VICIANO JOSE MARIA;ROIG COLUBI VICENTE;PARRARIBES JOSE PASCUAL;ARRUFAT BORT JOSE PASCUAL. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 210, S 8, H CS 12213, I/A 76(16.02.15).
23 de Febrero de 2015Revocaciones. Gerente: FRANCH PERSONAT MANUEL. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 209, S 8, H CS 12213, I/A 72(16.02.15).
Revocaciones. Apoderado: CASAS TRAVER ROSER. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 209, S 8, H CS 12213, I/A 73(16.02.15).
Revocaciones. Apoderado: PARRA RIBES JOSE PASCUAL. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 209, S 8, H CS 12213, I/A 74(16.02.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: ARRUFAT BORT JOSE PASCUAL;PARRA RIBES JOSE PASCUAL;CADROY VICIANO JOSE MARIA.Datos registrales. T 1503, L 1065, F 210, S 8, H CS 12213, I/A 75 (16.02.15).
Revocaciones. Apoderado: PEREA SERRANO ALFONSO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 210, S 8, H CS 12213, I/A 77(16.02.15).
Revocaciones. Apoderado: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 210, S 8, H CS 12213, I/A 78(16.02.15).
Revocaciones. Apoderado: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 210, S 8, H CS 12213, I/A 79(16.02.15).
20 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE;ROS MONTESINOS JOSE VICENTE. Apo.Sol.: FALOMIR
10 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCH PERSONAT JOSE ANTONIO;PARRA RIBES JOSE PASCUAL;CADROY VICIANODANIEL;CADROY VICIANO JOSE MARIA;FRANCH PERSONAT SANTIAGO;FRANCH PERSONAT MANUEL. Presidente: PARRARIBES JOSE PASCUAL. Consejero: ARRUFAT PARRA MANUEL VICENTE;ARRUFAT GALLEN ELISEO. Con.Delegado: FRANCH
Declaración de unipersonalidad. Socio único: VOCEX CORPORACION EMPRESARIAL S.A. Datos registrales. T 1503, L 1065,F 208, S 8, H CS 12213, I/A 70 ( 3.04.14).
17 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCH PERSONAT ALFONSO. Nombramientos. Consejero: FRANCH PERSONAT JOSEANTONIO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 207, S 8, H CS 12213, I/A 68 ( 7.02.14).
24 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 207, S 8, H CS 12213, I/A67 (16.12.13).
24 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMGAUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 206, S 8, H CS 12213, I/A 66 (17.12.12).
11 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: PEREA SERRANO ALFONSO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 206, S 8, H CS 12213, I/A 64(30.09.11).
Revocaciones. Apoderado: CAMAÑES OCHANDO MARIA FERNANDA. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 206, S 8, H CS12213, I/A 65 (30.09.11).
28 de Septiembre de 2011Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ARRUFAT BORT ELISEO;PARRA ROIG ANA;ARRUFAT BORT JOSEPASCUAL. Nombramientos. Consejero: ARRUFAT PARRA MANUEL VICENTE;ARRUFAT GALLEN ELISEO;ARRUFAT MILLANPASCUAL MARTIN Reelecciones. Consejero: PARRA RIBES JOSE PASCUAL;CADROY VICIANO DANIEL;FRANCH PERSONATSANTIAGO;CADROY VICIANO JOSE MARIA;FRANCH PERSONAT ALFONSO;FRANCH PERSONAT MANUEL;PARRA BORRASPASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 206, S 8, H CS 12213, I/A 62 (19.09.11).
Ceses/Dimisiones. Secretario: ARRUFAT PARRA MANUEL VICENTE. Nombramientos. Secretario: ARRUFAT PARRA MANUELVICENTE. Reelecciones. Presidente: PARRA RIBES JOSE PASCUAL. Con.Delegado: FRANCH PERSONAT MANUEL. Datosregistrales. T 1503, L 1065, F 206, S 8, H CS 12213, I/A 63 (19.09.11).
05 de Agosto de 2010Revocaciones. Apo.D.Gral.: MARTINEZ DOMENECH JOSE PEDRO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 205, S 8, H CS 12213,I/A 61 (27.07.10).
08 de Enero de 2010Reducción de capital. Importe reducción: 300,00 Euros. Resultante Suscrito: 119.700,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 5º de los estatutos sociales, por Reducción de Capital social.. Datos registrales. T1503, L 1065, F 205, S 8, H CS 12213, I/A 60 (22.12.09).
05 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: PARRA BORRAS PASCUAL JOSE. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 205, S 8, H CS 12213, I/A58 (27.10.09).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ DOMENECH JOSE PEDRO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 205, S 8, H CS 12213, I/A59 (27.10.09).
01 de Septiembre de 2009Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 205, S8, H CS 12213, I/A 57 (24.08.09).
13 de Abril de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 876, L 443, F 154, S 8, HCS 12213, I/A 55 (31.03.09).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DOMENECH JOSE PEDRO. Datos registrales. T 1503, L 1065, F 205, S 8, H CS 12213,I/A 56 (31.03.09).