Actos BORME de Frutas Gonzalez Garzon Sl
21 de Enero de 2021Modificaciones estatutarias. 20潞.-.. Datos registrales. T 1499 , F 135, S 8, H M 16771, I/A 15 (14.01.21).
27 de Julio de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 46.577,50 Euros. Resultante Suscrito: 46.577,50 Euros. Datos registrales. T 832 , F 212,S 8, H M 16771, I/A 14 (19.07.16).
11 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Vicepresid.: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE.Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. Secretario: FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. Consejero: GONZALEZPALOMAR ANA MARIA. Con.Delegado: FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO. Consejero: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS.Presidente: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social.CTRA DE VILLAVERDE A VALLECAS Km 3.800 - MERCAMADR (MADRID). Datos registrales. T 832 , F 211, S 8, H M 16771, I/A12 (28.06.16).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GARZON JOSE LUIS. Apo.Manc.: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS;FERNANDEZGARCIA FRANCISCO JOSE;FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO;GONZALEZ PALOMAR ANA MARIA. Datos registrales. T 832, F 212, S 8, H M 16771, I/A 13 (29.06.16).
18 de Junio de 2015Nombramientos. Consejero: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS. Presidente: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS. Datosregistrales. T 832 , F 211, S 8, H M 16771, I/A 11 (11.06.15).
20 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS. Presidente: GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS. Datos