Actos BORME de Fuenllana Centro Cultural Pedralta Sa
17 de Abril de 2023Nombramientos. Consejero: ANDREU MOLINA ENRIQUE. Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESASASOCIADOS SL. Datos registrales. T 21796 , F 220, S 8, H M 59769, I/A 100 (10.04.23).
21 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL MIRO IGNACIO SANTIAGO. Datos registrales. T 21796 , F 219, S 8, H M 59769, I/A 99(14.09.22).
21 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ-BRAVO MARTINEZ MARIA;MORAL GARCIA LORETO;DUGO TRUJILLOCARMEN;CARREÑO ESTRADA MARIA JESUS. Datos registrales. T 21796 , F 219, S 8, H M 59769, I/A 98 (14.03.22).
23 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ACOSTA NIETO RAFAEL JUSTINIANO. Presidente: ACOSTA NIETO RAFAEL JUSTINIANO.Nombramientos. Consejero: PASTOR QUINTANA PABLO. Presidente: PASTOR QUINTANA PABLO. Datos registrales. T 21796 ,F 218, S 8, H M 59769, I/A 97 (16.02.22).
19 de Marzo de 2020Nombramientos. Consejero: GIL MIRO IGNACIO SANTIAGO;PACO LANAU ANA MARIA. Reelecciones. Consejero: ACOSTANIETO RAFAEL JUSTINIANO. Presidente: ACOSTA NIETO RAFAEL JUSTINIANO. Datos registrales. T 21796 , F 218, S 8, H M59769, I/A 96 (12.03.20).
14 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: TELLO DE MENESES MERINO LUISA FERNANDA. Datos registrales. T 21796 , F 218, S 8, H M59769, I/A 95 ( 7.01.20).
06 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: JEREZ DELGADO CARMEN;FERRER NAVARRO MANUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero:DIAZ SOLOAGA PALOMA. Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Consejero: TELLO DEMENESES MERINO LUISA FERNANDA;DE LA PUENTE MORA-FIGUEROA PATRICIA. Modificaciones estatutarias. Fecha deCierre de Ejercicio: 31/8. 3. Modificación de los artículos 3º, 13º y 24º de los estatutos sociales.. Página web de la sociedad.Creación de la página web corporativa: www.fuenllana.net. Datos registrales. T 21796 , F 217, S 8, H M 59769, I/A 94 (30.07.19).
31 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ BLAZQUEZ ALMUDENA;SOGUERO FERRANDO MARGARITA;LAZARO LOPEZREBECA;GIL MENDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 21796 , F 217, S 8, H M 59769, I/A 93 (27.05.19).
23 de Noviembre de 2018Cambio de domicilio social. TRVA DE FUENTECISNEROS 1 (ALCORCON). Datos registrales. T 21796 , F 216, S 8, H M 59769,I/A 92 (16.11.18).
13 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CORREDOIRA Y ALFONSO LORETO. SecreNoConsj: SANCHEZ BLAZQUEZ ALMUDENA.
06 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Presidente: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Nombramientos.Presidente: ACOSTA NIETO RAFAEL JUSTINIANO. Reelecciones. Vicepresid.: GONZALEZ ROLDAN ISABEL. Datos registrales.T 21796 , F 216, S 8, H M 59769, I/A 90 (27.02.18).
11 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: CARREÑO ESTRADA MARIA JESUS. Apoderado: DUGO TRUJILLO CARMEN. Apo.Manc.: RUIZSANCHEZ MARIA ANGELES. Nombramientos. Apo.Manc.: DUGO TRUJILLO CARMEN;CARREÑO ESTRADA MARIAJESUS;RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 21796 , F 215, S 8, H M 59769, I/A 89 ( 3.01.18).
05 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ BLAZQUEZ ALMUDENA. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ BLAZQUEZALMUDENA. Reelecciones. Presidente: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Vicepresid.: GONZALEZ ROLDAN ISABEL. Datosregistrales. T 21796 , F 215, S 8, H M 59769, I/A 88 (29.08.17).
08 de Mayo de 2017Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 21796 , F 214, S 8, H M 59769,I/A 87 (26.04.17).
13 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ APARICIO VICTORIA. Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES.Datos registrales. T 21796 , F 214, S 8, H M 59769, I/A 86 ( 4.10.16).
11 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: HUERTA GONZALEZ ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: FERRER NAVARRO MANUELANGEL. Reelecciones. Consejero: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Presidente: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Vicepresid.:GONZALEZ ROLDAN ISABEL. SecreNoConsj: SANCHEZ BLAZQUEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 21796 , F 213, S 8, H M59769, I/A 85 ( 4.07.16).
25 de Noviembre de 2015Reelecciones. Consejero: JEREZ DELGADO CARMEN. Datos registrales. T 21796 , F 212, S 8, H M 59769, I/A 83 (18.11.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: OCAÑA TEJEDOR MARIA AUREA. Nombramientos. Apoderado: DUGO TRUJILLO CARMEN. Datosregistrales. T 21796 , F 213, S 8, H M 59769, I/A 84 (18.11.15).
04 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 21796 , F 212, S 8, H M 59769,I/A 82 (26.11.14).
18 de Agosto de 2014Nombramientos. Consejero: TELLO DE MENESES MERINO LUISA FERNANDA;ACOSTA NIETO RAFAEL JUSTINIANO;DE LAPUENTE MORA-FIGUEROA PATRICIA. Datos registrales. T 21796 , F 212, S 8, H M 59769, I/A 81 ( 7.08.14).
17 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ-LAORGA TORRIJOS MARIA ANTONIA;DIAZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. Consejero: HUERTA GONZALEZ ENRIQUE;CORREDOIRA Y ALFONSO LORETO. Reelecciones. Consejero:GONZALEZ ROLDAN ISABEL. Vicepresid.: GONZALEZ ROLDAN ISABEL. Datos registrales. T 21796 , F 211, S 8, H M 59769, I/A80 ( 9.12.13).
26 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OLMEDO VAREA MARIA PILAR. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ BLAZQUEZALMUDENA. Reelecciones. Consejero: DIAZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 21796 , F 211, S 8, H M59769, I/A 79 (15.06.12).
13 de Enero de 2012Revocaciones. Apoderado: VIDAL HEREDERO ENRIQUETA;VIDAL HEREDERO ENRIQUETA. Nombramientos. Apoderado:SANCHEZ BLAZQUEZ ALMUDENA;SANCHEZ BLAZQUEZ ALMUDENA;SOGUERO FERRANDO MARGARITA;SOGUEROFERRANDO MARGARITA;LAZARO LOPEZ REBECA;LAZARO LOPEZ REBECA;GIL MENDEZ BEATRIZ;GIL MENDEZ BEATRIZ.Datos registrales. T 21796 , F 210, S 8, H M 59769, I/A 78 ( 3.01.12).
06 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: OLMEDO VAREA MARIA PILAR. Consejero: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Presidente: PEREZCALOT JUAN ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: OLMEDO VAREA MARIA PILAR. Consejero: PEREZ CALOT JUANENRIQUE. Presidente: PEREZ CALOT JUAN ENRIQUE. Datos registrales. T 21796 , F 210, S 8, H M 59769, I/A 77 (27.06.11).
26 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 21796 , F 209, S 8, H M 59769,I/A 76 (12.04.11).
17 de Agosto de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 705.790,82 Euros. Desembolsado: 705.790,82 Euros. Resultante Suscrito: 14.542.562,16 Euros.Resultante Desembolsado: 14.542.562,16 Euros. Datos registrales. T 21796 , F 208, S 8, H M 59769, I/A 75 ( 5.08.10).
22 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: JAUDENES RUIZ ATAURI BELEN. Nombramientos. Consejero: JEREZ DELGADO CARMEN.Datos registrales. T 21796 , F 208, S 8, H M 59769, I/A 74 (12.07.10).
15 de Abril de 2010Cambio de domicilio social. C/ ZURBANO 94 4º (MADRID). Datos registrales. T 21796 , F 208, S 8, H M 59769, I/A 73 ( 5.04.10).
26 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ APARICIO VICTORIA;OCAÑA TEJEDOR MARIA AUREA. Datos registrales. T 21796 , F208, S 8, H M 59769, I/A 72 (16.02.10).
04 de Febrero de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ APARICIO VICTORIA;OCAÑA TEJEDOR MARIA AUREA;CARREÑO ESTRADA MARIAJESUS Datos registrales. T 21796 , F 207, S 8, H M 59769, I/A 71 (25.01.10).
28 de Enero de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 150.000,34 Euros. Desembolsado: 150.000,34 Euros. Resultante Suscrito: 13.836.771,34 Euros.Resultante Desembolsado: 13.836.771,34 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 5. Capital Social. 5.
11 de Marzo de 2009Ampliación de capital. Suscrito: 1.700.011,88 Euros. Desembolsado: 1.700.011,88 Euros. Resultante Suscrito: 13.686.771,00 Euros.Resultante Desembolsado: 13.686.771,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 5. CapitalSocial..Artículo 6. Clase y serie de acciones.-. Datos registrales. T 21796 , F 205, S 8, H M 59769, I/A 69 ( 2.03.09).
02 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CORREDOIRA ALFONSO LORETO. Nombramientos. Consejero: PEREZ-LAORGA TORRIJOSMARIA ANTONIA. Datos registrales. T 21796 , F 205, S 8, H M 59769, I/A 68 (19.02.09).