Actos BORME de Fuenteblandor Holding Sociedad Limitada
17 de Abril de 2023Nombramientos. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SLP. Datos registrales. T 1235 , F 165, S 8, H LE 21589, I/A 9(11.04.23).
13 de Febrero de 2017Nombramientos. Con.Delegado: GONZALEZ ALVAREZ CESAREO. Otros conceptos: Constataci贸n del cambio del c贸digoC.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el: 6420. Datos registrales. T 1235 , F 162, S 8, H LE 21589, I/A 4(24.01.17).
Otros conceptos: Establecimiento del car谩cter RETRIBUIDO del cargo de Consejero Delegado, y consecuente modificaci贸n y nuevaredacci贸n del Art铆culo 13潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1235 , F 162, S 8, H LE 21589, I/A 5 (24.01.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ GONZALEZ MARIA PURIFICACION;GONZALEZ ALVAREZ JAVIER;GONZALEZALVAREZ NOELIA;GONZALEZ ALVAREZ CESAREO;GONZALEZ GARCIA CESAREO. Secretario: GONZALEZ ALVAREZCESAREO. Con.Delegado: GONZALEZ ALVAREZ CESAREO. Presidente: GONZALEZ GARCIA CESAREO. Nombramientos. Adm.Unico: GONZALEZ ALVAREZ CESAREO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Establecimiento del car谩cter RETRIBUIDO del cargo de Administrador y consecuente modificaci贸n y nuevaredacci贸n del Art铆culo 13潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1235 , F 163, S 8, H LE 21589, I/A 6 (24.01.17).
Cambio de domicilio social. AVDA SAN IGNACIO 177 (SAN ANDRES DEL RABANEDO). Datos registrales. T 1235 , F 163, S 8, HLE 21589, I/A 7 (24.01.17).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GARCIA CESAREO. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ ALVAREZNOELIA;GONZALEZ ALVAREZ JAVIER. Datos registrales. T 1235 , F 164, S 8, H LE 21589, I/A 8 (24.01.17).
12 de Marzo de 2015Cambio de objeto social. CNAE Actividad Principal: 7010. Se amplia el objeto social entre otras actividades: "La compraventa,arrendamiento y explotaci贸n de toda clase de bienes inmuebles, tales como solares, terrenos, edificios constituidos o no en r茅gimen depropiedad horizontal, locales, vivientas, fincas r煤sticas...". Datos registrales. T 1235 , F 161, S 8, H LE 21589, I/A 3 ( 5.03.15).
26 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GARCIA CESAREO. Datos registrales. T 1235 , F 161, S 8, H LE 21589, I/A 2(17.07.12).
07 de Junio de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.04.12. Objeto social: La gesti贸n de acciones o participaciones representativas del capitalsocial y de los derechos econ贸micos y pol铆ticos de sociedades y entidades de cualquier clase, as铆 como la gesti贸n y organizaci贸n delos recursos materialesy humanos de las sociedades participadas. Domicilio: POLIG INDUSTRIAL DE ONZONILLA - FASE II, CALLEC, (SANTOVENIA DE LA VALDONCINA.Capital: 4.531.136,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARCIA CESAREO.Presidente: GONZALEZ GARCIA CESAREO. Consejero: GONZALEZ ALVAREZ CESAREO. Secretario: GONZALEZ ALVAREZCESAREO. Consejero: ALVAREZ GONZALEZ MARIA PURIFICACION;GONZALEZ ALVAREZ NOELIA;GONZALEZ ALVAREZJAVIER. Datos registrales. T 1235 , F 159, S 8, H LE 21589, I/A 1 (29.05.12).