Actos BORME de Fuerzas Energeticas Del Sur De Europa Xi Sl
18 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CIBEIRA MOREIRA ROBERTO. Vicesecret.: CIBEIRA MOREIRA ROBERTO. Nombramientos.Consejero: IGLESIAS BOTAS IGNACIO. Vicesecret.: MORENO FERNANDEZ ANDRES. Datos registrales. T 43291 , F 203, S 8, HM 646593, I/A 29 (11.12.23).
02 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TREJO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 43291 , F 202, S 8, H M 646593, I/A 26(26.05.23).
Nombramientos. Apoderado: VILLORIA MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 43291 , F 202, S 8, H M 646593, I/A 27(26.05.23).
Revocaciones. Apoderado: LARA GARCIA LEOPOLDO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 43291 , F 203, S
09 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43291 , F 201, S 8, H M 646593,I/A 25 ( 2.02.23).
21 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 43291 , F 201, S 8, H M 646593, I/A 24(14.11.22).
09 de Junio de 2022Reelecciones. Consejero: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;MORENO FERNANDEZ ANDRES;CIBEIRA MOREIRA ROBERTO.Secretario: GARCIA-RUBIO JAQUOTOT JAVIER. Consejero: COSTEIRA NOGUEIRA DE SOUSA JOAO PAULO;GOMEZ REDONDOSERGIO ALFONSO. Presidente: COSTEIRA NOGUEIRA DE SOUSA JOAO PAULO. Vicesecret.: CIBEIRA MOREIRA ROBERTO.Datos registrales. T 40446 , F 17, S 8, H M 646593, I/A 22 ( 2.06.22).
20 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGO ALMUDENA;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datosregistrales. T 40446 , F 17, S 8, H M 646593, I/A 21 (12.05.22).
11 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;GOMEZ REDONDO SERGIO ALONSO;DE LALAMA ALCAIDE JOSE MANUEL;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datos registrales. T 40446 , F 16, S 8, H M 646593, I/A 20 ( 4.05.22).
21 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ HIERROFRANCISCO;MORENO FERNANDEZ ANDRES;CIBEIRA MOREIRA ROBERTO. Secretario: GARCIA-RUBIO JAQUOTOT JAVIER.Consejero: COSTEIRA NOGUEIRA DE SOUSA JOAO PAULO;GOMEZ REDONDO SERGIO ALFONSO. Presidente: COSTEIRANOGUEIRA DE SOUSA JOAO PAULO. Vicesecret.: CIBEIRA MOREIRA ROBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 40446 , F 15, S 8, H M 646593, I/A 19(14.01.22).
22 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 40446 , F 15, S 8, H M 646593, I/A 18(15.09.21).
06 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 40446 , F 14, S 8, H M 646593, I/A 17(29.06.21).
27 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: ROJO MARTINEZ PEDRO LUIS. Datos registrales. T 40446 , F 14, S 8, H M 646593, I/A 16(20.05.21).
22 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 40446 , F 14, S 8, H M 646593, I/A 15(15.04.21).
13 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ GENERAL LACY 23 (MADRID). Datos registrales. T 40446 , F 14, S 8, H M 646593, I/A 14 (2.04.20).
24 de Febrero de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: REPSOL RENOVABLES SL. Datos registrales. T 35987 , F 44, S 8,H M 646593, I/A 13 (17.02.20).
19 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MOURILLE CASTI脩EIRAS SANTOS;PEINADO BALDRICH IRENE;DE MIGUEL CALABIA CRISTINA.Datos registrales. T 35987 , F 44, S 8, H M 646593, I/A 12 (12.02.20).
04 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 35987 , F 43, S 8, H M 646593, I/A11 (28.01.20).
12 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGOALMUDENA;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datos registrales. T 35987 , F 42, S 8, H M 646593, I/A 9 ( 5.11.19).
Nombramientos. Apoderado: SAMPER RIVAS FERNANDO;ONTA脩ON CARRERA CARLOS;MARRUEDO ESPEJA LUIS;VICENTELOZANO MARIA. Datos registrales. T 35987 , F 43, S 8, H M 646593, I/A 10 ( 5.11.19).
23 de Octubre de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: REPSOL NUEVAS ENERGIAS SOCIEDAD ANONIMA.Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDO SOL SL. Representan: SAMPER RIVAS FERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico:CORTEZON SANTACLARA JULIO. Datos registrales. T 35987 , F 40, S 8, H M 646593, I/A 7 (16.10.19).
Nombramientos. Apoderado: LARA GARCIA LEOPOLDO. Datos registrales. T 35987 , F 41, S 8, H M 646593, I/A 8 (17.10.19).
07 de Junio de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO EMPRESARIAL ENERGETICA DEL SUR DE EUROPASOC. Datos registrales. T 35987 , F 40, S 8, H M 646593, I/A 6 (31.05.19).
28 de Enero de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 42.859,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.859,00 Euros. Datos registrales. T 35987 , F 40, S 8, H M646593, I/A 5 (21.01.19).
07 de Diciembre de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORONATION HOLDCO RENOVABLES SL. Datos registrales. T35987 , F 39, S 8, H M 646593, I/A 4 (28.11.18).
09 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 20, - 2陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 35987 , F 39, S 8, HM 646593, I/A 3 ( 1.03.18).
21 de Noviembre de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SOCIEDAD ARAGONESA TRANSEUROPEA DE ENERGIASRENOVA. Datos registrales. T 35987 , F 39, S 8, H M 646593, I/A 2 (13.11.17).
25 de Mayo de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.05.17. Objeto social: - La promoci贸n, construcci贸n y subsiguiente explotaci贸n o venta decentrales de energ铆a el茅ctrica producida por el aprovechamiento de recursos e贸licos... Domicilio: C/ GENOVA 12 1陋 B (MADRID).Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FERNANDO SOL SL. Nombramientos. Adm. Unico:FERNANDO SOL SL. Representan: SAMPER RIVAS FERNANDO. Datos registrales. T 35987 , F 36, S 8, H M 646593, I/A 1(17.05.17).