Buscador CIF Logo

Actos BORME Funsureste Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Funsureste Sl

Actos BORME Funsureste Sl - B30134639

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Funsureste Sl con CIF B30134639

馃敊 Perfil de Funsureste Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Funsureste Sl

30 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: TOBOSO RAMON LUIS. Nombramientos. Consejero: TOBOSO RAMON JULIO ANTONIO. Datosregistrales. T 3405 , F 180, S 8, H A 114445, I/A 28 (22.08.23).

07 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3405 , F 180, S 8, H A 114445, I/A 27(30.01.23).

24 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN;LOPEZ PEREZ ANTONIO MANUEL;NAVARRO BA脩ON JOSEMARIA;SAMPER FUNESER SL. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Con.Delegado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA.Nombramientos. Consejero: GUNTI脩AS SOLBES FERNANDO;CARRE脩O FERNANDEZ FRANCISCA. Presidente: CARRE脩OFERNANDEZ FRANCISCA. Con.Delegado: CARRE脩O FERNANDEZ FRANCISCA. Reelecciones. Consejero: BAEZA PASTORANDRES;TOBOSO RAMON LUIS;SANCHEZ BELTRAN JUAN FRANCISCO. Secretario: BAEZA PASTOR ANDRES. Datosregistrales. T 3405 , F 180, S 8, H A 114445, I/A 26 (16.06.22).

15 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTO MARTINEZ ESMERALDO. Datos registrales. T 3405 , F 180, S 8, H A 114445, I/A 25 (8.02.22).

07 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3405 , F 180, S 8, H A 114445, I/A 24 (26.11.21).

07 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: BROTONS CANO MIGUEL. Datos registrales. T 3405 , F 180, S 8, H A 114445, I/A 23 (31.05.21).

04 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: PAYA CAYUELAS JOSE JUAN;CARRE脩O FERNANDEZ FRANCISCA. Datos registrales. T 3329 , F196, S 8, H A 114445, I/A 21 (26.05.21).

Nombramientos. Apoderado: BAEZA PASTOR ANDRES. Datos registrales. T 3329 , F 196, S 8, H A 114445, I/A 22 (28.05.21).

02 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN. Apoderado: BROTONS CANO MIGUEL. Datos registrales. T 3329 , F196, S 8, H A 114445, I/A 20 (26.05.21).

17 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ PEREZ ANTONIO MANUEL;NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA;BAEZA PASTORANDRES;RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN;SANCHEZ BELTRAN JUAN FRANCISCO;TOBOSO RAMON LUIS;SAMPER FUNESERSL. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Con.Delegado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Secretario: BAEZA PASTORANDRES. Nombramientos. Consejero: RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN;SAMPER FUNESER SL;TOBOSO RAMONLUIS;SANCHEZ BELTRAN JUAN FRANCISCO;BAEZA PASTOR ANDRES;NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA;LOPEZ PEREZANTONIO MANUEL;QUINTO MARTINEZ ESMERALDO. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Secretario: BAEZA PASTORANDRES. Con.Delegado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.322,55 Euros. Resultante Suscrito:217.898,75 Euros. Datos registrales. T 3329 , F 196, S 8, H A 114445, I/A 19 ( 7.06.19).

04 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3329 , F 149, S 8, H A 114445, I/A 18 (21.12.18).

04 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Consejero: LOPEZ PEREZ ANTONIO MANUEL.Nombramientos. Consejero: LOPEZ PEREZ ANTONIO MANUEL. Con.Delegado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Reelecciones.Consejero: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA;BAEZA PASTOR ANDRES;RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN;SANCHEZ BELTRANJUAN FRANCISCO;TOBOSO RAMON LUIS;SAMPER FUNESER SL. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Secretario:BAEZA PASTOR ANDRES. Datos registrales. T 3329 , F 149, S 8, H A 114445, I/A 17 (26.06.18).

28 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ RAMON MANUEL VICTOR. Nombramientos. Consejero: LOPEZ PEREZ ANTONIOMANUEL. Datos registrales. T 3329 , F 149, S 8, H A 114445, I/A 16 (18.08.17).

09 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: PAYA CAYUELAS GUILLERMO. Datos registrales. T 3329 , F 149, S 8, H A 114445, I/A 15 (1.09.16).

23 de Junio de 2016
Cambio de domicilio social. AVDA JEAN CLAUDE COMBALDIEU 5 (ALICANTE). Datos registrales. T 3329 , F 148, S 8, H A114445, I/A 14 (15.06.16).

15 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3329 , F 148, S 8, H A 114445, I/A 13 ( 7.01.16).

09 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ BELTRAN JUAN FRANCISCO;TOBOSO RAMON LUIS;LOPEZ RAMON MANUELVICTOR;PEREZ SAMPER ARENAS JOSE MIGUEL;BAEZA PASTOR ANDRES;NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA;RAIGON ARIZAACISCLO RUBEN. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Secretario: BAEZA PASTOR ANDRES. Con.Delegado: NAVARROBA脩ON JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA;BAEZA PASTOR ANDRES;LOPEZ RAMONMANUEL VICTOR;RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN;SANCHEZ BELTRAN JUAN FRANCISCO;TOBOSO RAMON LUIS;SAMPERFUNESER SL. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Secretario: BAEZA PASTOR ANDRES. Con.Delegado: NAVARROBA脩ON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3329 , F 148, S 8, H A 114445, I/A 12 ( 1.07.15).

26 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ RAMON ELIAS;MANZANO RODRIGUEZ JUAN FAUSTINO;SAMPER MARTINEZJULIO;VACA PE脩A JOSE MIGUEL;PAYA CAYUELAS JOSE JUAN. Presidente: PAYA CAYUELAS JOSE JUAN. Con.Delegado:PAYA CAYUELAS JOSE JUAN. Secretario: BAEZA PASTOR ANDRES. Nombramientos. Presidente: NAVARRO BA脩ON JOSEMARIA. Secretario: BAEZA PASTOR ANDRES. Con.Delegado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero:SANCHEZ BELTRAN JUAN FRANCISCO;TOBOSO RAMON LUIS;LOPEZ RAMON MANUEL VICTOR;PEREZ SAMPER ARENASJOSE MIGUEL;BAEZA PASTOR ANDRES;NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA;RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN. Datos registrales.T 3329 , F 148, S 8, H A 114445, I/A 11 (14.03.12).

28 de Octubre de 2011
Cambio de domicilio social. AVDA DEL ALCALDE LORENZO CARBONELL 67 (ALICANTE). Datos registrales. T 3329 , F 148, S8, H A 114445, I/A 10 (18.10.11).

13 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: BROTONS CANO MIGUEL. Datos registrales. T 3329 , F 148, S 8, H A 114445, I/A 9 ( 2.11.09).

20 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: RAIGON ARIZA ACISCLO RUBEN;PEREZ SAMPER ARENAS JOSE MIGUEL;LOPEZ PEREZ ANTONIOMANUEL. Datos registrales. T 3329 , F 49, S 8, H A 114445, I/A 8 ( 9.03.09).

18 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO BA脩ON JOSE MARIA. Datos registrales. T 3329 , F 49, S 8, H A 114445, I/A 7 ( 9.03.09).

26 de Enero de 2009
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Capital: 71.951,67 Euros. Resultante Suscrito: 205.576,20 Euros.Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TANATORIO FUNERARIA VEGA BAJA SL. Datos registrales. T 3329 , F 48, S 8, HA 114445, I/A 6 (14.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n