Actos BORME de Funtasmix Internacional Sl
14 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: VALDES MALDONADO JOSE LUIS;PEDROSA NEGRETE EDUARDO;ALLES CAMPSOSCAR;CAÑIZARES SANTOS YOLANDA;PERAL LEYVA ANA;NUÑEZ MESTRE VICTORIA;COSTANZO ANTONELLAROMINA;COSTANZO ANTONELLA ROMINA. Datos registrales. T 27110 , F 12, S 8, H M 488448, I/A 14 ( 7.03.22).
28 de Octubre de 2021Cambio de domicilio social. C/ JUAN DE LA CIERVA 63 - POLIGONO INDUSTRIAL VALD (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 27110 , F 9, S 8, H M 488448, I/A 12 (21.10.21).
Nombramientos. Apoderado: CAFFER AVANTHAY SOFIA. Datos registrales. T 27110 , F 10, S 8, H M 488448, I/A 13 (21.10.21).
24 de Agosto de 2018Cambio de domicilio social. PLAZA SANTA MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA 1 4ª (MADRID). Datos registrales. T 27110 , F9, S 8, H M 488448, I/A 11 (16.08.18).
14 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 136 - ESCALERA 1ª, SEMISOTANO, PUIERT (MADRID). Datos registrales. T 27110, F 9, S 8, H M 488448, I/A 10 ( 2.11.17).
25 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: COSTANZO ANTONELLA ROMINA. Datos registrales. T 27110 , F 8, S 8, H M 488448, I/A 9(18.04.17).
10 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: COSTANZO ANTONELLA ROMINA. Datos registrales. T 27110 , F 8, S 8, H M 488448, I/A 8(31.03.17).
14 de Abril de 2016Declaración de unipersonalidad. Socio único: PERIALES LUCIANA. Datos registrales. T 27110 , F 8, S 8, H M 488448, I/A 7 (6.04.16).
23 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ESTEBAN PERIALES MARCELO;HUMBERTO PERIALES DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico:PERIALES LUCIANA. Modificaciones estatutarias. - Modificado el artículo 16 de los Estatutos Sociales.. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 27110 , F 7, S 8, H M488448, I/A 5 (13.04.15).
Cambio de domicilio social. C/ JUAN DE LA CIERVA 63 - POLIGONO VALDEARENAL NOR (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 27110 , F 8, S 8, H M 488448, I/A 6 (13.04.15).
18 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. C/ CAMILO JOSE CELA, NUMERO 2, LOCAL 18, CENTRO CO (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 27110 , F 7, S 8, H M 488448, I/A 4 ( 6.05.10).
03 de Diciembre de 2009Cambio de domicilio social. CTRA NACIONAL V Km 23,5 - LOCAL Nº 120, CENTRO COM (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 27110 , F 7, S 8, H M 488448, I/A 2 (23.11.09).
Nombramientos. Apoderado: ALLES CAMPS OSCAR;CAÑIZARES SANTOS YOLANDA;PERAL LEYVA ANA;NUÑEZ MESTREVICTORIA Datos registrales. T 27110 , F 7, S 8, H M 488448, I/A 3 (23.11.09).
14 de Enero de 2009Revocaciones. APODERADO: PABLO IGNACIO MORAGREGA. Datos registrales. T 35100 , F 107, S 8, H B 260923, I/A 7(30.12.08).