Actos BORME de Fusgalian Sl
30 de Junio de 2021Nombramientos. Cons.Del.Sol: NAVALPOTRO FUSTER JORGE CARLOS;NAVALPOTRO PASCUAL CARLOS. Datos registrales.T 16549 , F 225, S 8, H M 281937, I/A 11 (23.06.21).
23 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FUSTER GALIANA MARIA DOLORES. Nombramientos. Consejero: NAVALPOTRO PASCUALCARLOS;NAVALPOTRO FUSTER JORGE CARLOS;NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO;NAVALPOTRO FUSTERLOURDES. Presidente: NAVALPOTRO FUSTER JORGE CARLOS. Secretario: NAVALPOTRO FUSTER LOURDES. Modificacionesestatutarias. Modificados los art铆culos 5潞, 6潞 y 21潞 de los estatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Reducci贸n del valor nominal de las participaciones de la serie B,canjeando 377 participaciones de 1000E en 377.000 participaciones de 1E. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 5潞 de los estatutossociales. Datos registrales. T 16549 , F 223, S 8, H M 281937, I/A 10 (16.06.21).
16 de Marzo de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 62.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 645.006,00 Euros. Datos registrales. T 16549 , F223, S 8, H M 281937, I/A 9 ( 9.03.20).
11 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: NAVALPOTRO PASCUAL CARLOS;NAVALPOTRO FUSTER JORGE CARLOS. Datos registrales. T16549 , F 223, S 8, H M 281937, I/A 8 ( 4.02.20).
19 de Diciembre de 2013Cambio de domicilio social. C/ RIO GENIL 7 (GETAFE). Datos registrales. T 16549 , F 222, S 8, H M 281937, I/A 7 (11.12.13).