Actos BORME de Fusopar Sicav Sa
25 de Noviembre de 2021Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 30016 , F 46, S 8, H M 540214, I/A 15 (18.11.21).
25 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30016 , F 46, S 8, H M 540214, I/A14 (18.10.21).
27 de Julio de 2021Otros conceptos: INSERTADO CON FECHA 19 DE MAYO DE 2021, EN LA PAGINA WEB CORPORATIVA DE LA SOCIEDADGESTORA "WWW.CAIXABANKASSETMANAGEMENT.COM" EL PROYECTO COMUN DE FUSION POR ABSORCION DE LASSOCIEDAD "FUSOPAR SICAV, SA", COMO ABSORBIDA Y "FUERIBEX SICAV, SA", COMO SOCIEDAD ABSORBENTE.- Datosregistrales. T 30016 , F 30, S 8, H M 540214, I/A 1-M (20.07.21).
09 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Ent. Gestora: MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA. EntidDeposit: BANCA MARCH SA. Revocaciones.Apoderado: MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA. Nombramientos. Ent. Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIICSA. EntidDeposit: CECABANK SA. Apoderado: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA. Modificaciones estatutarias.Modificacion del articulo 1 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la sustitución de la Entidad Depositaria. Cambio dedomicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA - NUMERO 51 (MADRID). Datos registrales. T 30016 , F 44, S 8, H M 540214, I/A13 ( 2.06.21).
26 de Noviembre de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Disminuaciónde las cifras de capital social mínimo y de capital estatutario máximo, que quedan establecidas de la siguiente manera: Capital inicial:2.404.000 euros y Capital estatutario máximo: 24.040.000 euros. Datos registrales. T 30016 , F 44, S 8, H M 540214, I/A 12(19.11.20).
25 de Septiembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30016 , F 43, S 8, H M 540214, I/A11 (18.09.20).
29 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Cons.Del.Sol: FUERTES FERNANDEZ JOSE. Consejero:FUERTES FERNANDEZ JOSE;FUERTES FERNANDEZ TOMAS;FUERTES FERNANDEZ JUANA. Presidente: FUERTESFERNANDEZ TOMAS. Cons.Del.Sol: FUERTES FERNANDEZ TOMAS. SecreNoConsj: JUAN JOSE MELGAR MORAIS. Datosregistrales. T 30016 , F 42, S 8, H M 540214, I/A 10 (22.01.20).
05 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30016 , F 42, S 8, H M 540214, I/A9 (28.11.18).
10 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30016 , F 42, S 8, H M 540214, I/A8 ( 2.10.17).
10 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA. Datos registrales. T 30016 , F 41, S 8, H M 540214, I/A 7
03 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30016 , F 41, S 8, H M 540214, I/A6 (23.09.16).
22 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30016 , F 41, S 8, H M 540214, I/A5 (13.10.15).
08 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Cons.Del.Sol: FUERTES FERNANDEZ JOSE. Consejero:FUERTES FERNANDEZ JOSE;FUERTES FERNANDEZ TOMAS;FUERTES FERNANDEZ JUANA. Presidente: FUERTESFERNANDEZ TOMAS. Cons.Del.Sol: FUERTES FERNANDEZ TOMAS. Datos registrales. T 30016 , F 40, S 8, H M 540214, I/A 4
01 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 13º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 30016 , F40, S 8, H M 540214, I/A 3 (19.09.12).
20 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. C/ CASTELLO NUMERO 74 (MADRID). Datos registrales. T 30016 , F 40, S 8, H M 540214, I/A 2 (7.06.12).