Actos BORME de Futura Carbono Sl
08 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: AZEVEDO FIGUEIREDO PAULA ALEXANDRA;CACHIDE MACHADO BASTOS PAULA MARIA;AFONSOPARREIRO NUNO MIGUEL;LOURO DA PONTE RUI MIGUEL;QUINTAS DOS SANTOS RUI ALEXANDRE;FERREIRA DE CASTROROCHA LUIS FILIPE;DE SOUSA PEREIRA MARTINS AMARO CRISTIANO;TOLENTINO DA SILVA MARQUITOS FERREIRAMIGUEL;OLIVEIRA GONCALVES DE SAMPAIO MAIA MARIA JOANA. Datos registrales. T 34903 , F 74, S 8, H M 445322, I/A 36 (1.06.23).
09 de Mayo de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34903 , F 74, S 8, H M 445322, I/A35 (28.04.23).
10 de Octubre de 2022Cambio de domicilio social. C/ ULISES, 16-18, PLANTA 4陋. (MADRID). Datos registrales. T 34903 , F 74, S 8, H M 445322, I/A 34
15 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: AZEVEDO FIGUEIREDO PAULA ALEXANDRA;CACHIDE MACHADO BASTOS PAULAMARIA;AFONSO PARREIRO NUNO MIGUEL;LOURO DA PONTE RUI MIGUEL;QUINTAS DOS SANTOS RUIALEXANDRE;FERREIRA DE CASTRO ROCHA LUIS FILIPE;DE SOUSA PEREIRA MARTINS AMARO CRISTIANO;TOLENTINO DASILVA MARQUITOS FERREIRA MIGUEL;OLIVEIRA GONCALVES DE SAMPAIO MAIA MARIA JOANA. Datos registrales. T 34903 ,F 72, S 8, H M 445322, I/A 33 ( 8.04.21).
28 de Octubre de 2020Cambio de domicilio social. C/ RAMIREZ DE ARELLANO 21, PLANTA 4 (MADRID). Datos registrales. T 34903 , F 72, S 8, H M445322, I/A 32 (21.10.20).
17 de Agosto de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FUTURA ENERGIA INVERSIONES SL. Datos registrales. T 34903 , F 71, S 8, H M445322, I/A 31 (10.08.20).
12 de Junio de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 34903 , F 71, S 8, H M 445322,I/A 30 ( 5.06.20).
23 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE;PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA.Nombramientos. Consejero: FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL;MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE;PINHOTEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA. Presidente: MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE. Cons.Del.Man: MOREIRA DACRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE;PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA;FERREIRA DA ROCHA SERGIO MANUEL.SecreNoConsj: GONZALEZ GUGEL IGNACIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidariosa Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 34903 , F 71, S 8, H M 445322, I/A 29 (16.12.19).
12 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GISTAU COSCULLUELA IGNACIO;WINKELS MICHAEL PETER. Nombramientos. Adm. Solid.:MOREIRA DA CRUZ GIL MATA MIGUEL JORGE;PINHO TEIXEIRA DA SILVA IVONE MARIA. Datos registrales. T 34903 , F 70, S8, H M 445322, I/A 27 ( 5.09.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA TRAVADELA MARTA. Datos registrales. T 34903 , F 70, S 8, H M 445322, I/A 28 ( 5.09.19).
11 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 34903 , F 70, S 8, H M 445322, I/A 26 ( 4.03.19).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA TRAVADELA MARTA. Datos registrales. T 34903 , F 69, S 8, H M 445322, I/A 25 (30.10.18).
29 de Octubre de 2018Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO SILVELA 44, - 1潞-B (MADRID). Datos registrales. T 34903 , F 69, S 8, H M 445322,I/A 24 (19.10.18).
07 de Agosto de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 94.482,00 Euros. Resultante Suscrito: 136.557,00 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: FUTURA ENERGIA INVERSIONES SL. Datos registrales. T 34903 , F 67, S 8, H M 445322, I/A 23(28.07.17).
29 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GISTAU COSCULLUELA IGNACIO. Secretario: GISTAU COSCULLUELA IGNACIO. Consejero:PEREZ ANTU脩A ALBERTO. Presidente: PEREZ ANTU脩A ALBERTO. Consejero: WINKELS MICHAEL PETER. Nombramientos.Adm. Solid.: GISTAU COSCULLUELA IGNACIO;WINKELS MICHAEL PETER. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 34903 , F 67, S 8, H M 445322, I/A 22(22.06.17).
23 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ ANTU脩A ALBERTO. Datos registrales. T 34903 , F 66, S 8, H M 445322, I/A 21 (15.06.17).
26 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.810,00 Euros. Resultante Suscrito: 231.039,00 Euros. Datos registrales. T 34903 , F 65, S 8, HM 445322, I/A 20 (18.05.17).
31 de Enero de 2017Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 24737 , F 222, S 8, H M445322, I/A 10M (16.01.17).
22 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Apo.Manc.: GISTAU COSCULLUELA IGNACIO;GONZALEZ SAGUARAMADEO;GARCIA TRAVADELA MARTA;LOZANO MARTIN MARIA LUISA;GISTAU COSCULLUELA IGNACIO;CENTENOMALDONADO ALFONSO. Datos registrales. T 34903 , F 65, S 8, H M 445322, I/A 19 (11.11.16).
06 de Octubre de 2016Cambio de domicilio social. C/ PADRE JESUS ORDO脩EZ 18 - 2潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 34903 , F 65, S 8,H M 445322, I/A 18 (28.09.16).
03 de Octubre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 11.171,00 Euros. Resultante Suscrito: 212.229,00 Euros. Datos registrales. T 24737 , F 225, S 8, HM 445322, I/A 17 (22.09.16).
30 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Datos registrales. T 24737 , F 225, S 8, H M 445322, I/A 16(18.08.16).
05 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA TRAVADELA MARTA. Datos registrales. T 24737 , F 225, S 8, H M 445322, I/A 15(28.03.16).
22 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA TRAVADELA MARTA;LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Presidente: LOZANO MARTINMARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: PEREZ ANTU脩A ALBERTO. Presidente: PEREZ ANTU脩A ALBERTO. Consejero:WINKELS MICHAEL PETER. Datos registrales. T 24737 , F 224, S 8, H M 445322, I/A 14 (11.03.16).
18 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ ANTU脩A ALBERTO;WINKELS MICHAEL PETER. Datos registrales. T 24737 , F 223, S 8, H M
08 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. Modificacion de los articulos 2 y 7 de los estatutos sociales . Ampliacion del objeto social. Lacompraventa y/o compraventa de opciones, intermediaci贸n, comisi贸n, gesti贸n y administraci贸n de certificados de reducciones deemisiones, y derechos de emisi贸n de gases de efecto invernadero (C贸digo CNAE n煤mero 4618). Datos registrales. T 24737 , F 222,S 8, H M 445322, I/A 12 (30.09.15).
02 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: CENTENO MALDONADO ALFONSO. Datos registrales. T 24737 , F 222, S 8, H M 445322, I/A 11(25.09.15).
16 de Septiembre de 2015Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 24737 , F 222, S 8, H M 445322, I/A 10 (27.08.15).
11 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SAGUAR AMADEO;GARCIA TRAVADELA MARTA;LOZANO MARTIN MARIALUISA;GISTAU COSCULLUELA IGNACIO;CENTENO MALDONADO ALFONSO. Datos registrales. T 24737 , F 221, S 8, H M445322, I/A 9 ( 3.06.15).
25 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.052,00 Euros. Resultante Suscrito: 201.058,00 Euros. Datos registrales. T 24737 , F 220, S 8, HM 445322, I/A 8 (18.05.15).
15 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA TRAVADELA MARTA;LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Apo.Manc.: GISTAUCOSCULLUELA IGNACIO;CENTENO MALDONADO ALFONSO. Datos registrales. T 24737 , F 135, S 8, H M 445322, I/A 7 (7.04.15).
09 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: GARCIA TRAVADELAMARTA;LOZANO MARTIN MARIA LUISA;GISTAU COSCULLUELA IGNACIO. Presidente: LOZANO MARTIN MARIA LUISA.Secretario: GISTAU COSCULLUELA IGNACIO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 191.006,00Euros. Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 7潞 de los Estatutos Sociales.-. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Ampliacion del objeto social. La Sociedad tiene por objeto: Lacompraventa y/o compraventa de opciones, intermediaci贸n, comisi贸n, gesti贸n y administraci贸n de certificados de reducciones deemisiones, derechos de emisi贸n de gases de efecto invernadero (C贸digo CNAE. n煤mero 4618). Datos registrales. T 24737 , F 133, S8, H M 445322, I/A 6 (30.03.15).
12 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 48.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 51.006,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.000,00Euros. Resultante Suscrito: 121.006,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞. Capital.-. Datos
25 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROSIQUE GIMENEZ DAVID. Nombramientos. Adm. Unico: LOZANO MARTIN MARIA LUISA.Datos registrales. T 24737 , F 132, S 8, H M 445322, I/A 4 (17.03.14).
18 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Nombramientos. Adm. Unico: ROSIQUE GIMENEZ DAVID.Datos registrales. T 24737 , F 131, S 8, H M 445322, I/A 2 ( 5.11.09).
Nombramientos. Apoderado: LOZANO MARTIN MARIA LUISA. Datos registrales. T 24737 , F 131, S 8, H M 445322, I/A 3 (5.11.09).