Actos BORME de Fyce 2002 Distribucion Sl
27 de Septiembre de 2023Nombramientos. Auditor: ADADE AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 21(20.09.23).
21 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERO VELASCO JESUS. Presidente: HERRERO VELASCO JESUS. Consejero: CARRERACARRERA FERNANDO. Secretario: CARRERA CARRERA FERNANDO. Consejero: ROMERO LUJAN JAIRO JOSE.Nombramientos. Consejero: HERRERO VELASCO JESUS;ROMERO LUJAN JAIRO JOSE;CRESPO RIPOLL IGNACIO. Presidente:HERRERO VELASCO JESUS. Secretario: ROMERO LUJAN JAIRO JOSE. Datos registrales. T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 20(14.01.21).
15 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO LUJAN JAIRO JOSE;HERRERO VELASCO JESUS;RIPOLL ROYO FERNANDOJOSE;PANADES VILLAR JON;CERCADILLO CRESPO MIGUEL ANGEL;CARRERA CARRERA FERNANDO;VAZQUEZ GONZALEZBENIGNO. Secretario: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Presidente: HERRERO VELASCO JESUS. Vicepresid.: ROMERO LUJANJAIRO JOSE. Cons.Del.Man: HERRERO VELASCO JESUS;RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Nombramientos. Consejero:HERRERO VELASCO JESUS. Presidente: HERRERO VELASCO JESUS. Consejero: CARRERA CARRERA FERNANDO. Secretario:CARRERA CARRERA FERNANDO. Consejero: ROMERO LUJAN JAIRO JOSE. Datos registrales. T 4274 , F 32, S 8, H Z 32651,I/A 18 ( 8.01.20).
Revocaciones. Apoderado: ALDA FERNANDO MANUEL. Datos registrales. T 4274 , F 33, S 8, H Z 32651, I/A 19 ( 8.01.20).
02 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: LAZARO HEREDERO PABLO. Datos registrales. T 4274 , F 31, S 8, H Z 32651, I/A 17 (26.08.19).
07 de Junio de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 75.600,00 Euros. Datos registrales. T 4274 , F 31, S8, H Z 32651, I/A 16 (30.05.19).
20 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAR PEREZ PEDRO. Presidente: VILLAR PEREZ PEDRO. Vicesecret.: HERRERO VELASCOJESUS. Nombramientos. Consejero: ROMERO LUJAN JAIRO. Presidente: HERRERO VELASCO JESUS. Vicepresid.: ROMEROLUJAN JAIRO. Cons.Del.Man: HERRERO VELASCO JESUS;RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Reelecciones. Consejero:HERRERO VELASCO JESUS;RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE;PANADES VILLAR JON;CERCADILLO CRESPO MIGUELANGEL;CARRERA CARRERA FERNANDO;VAZQUEZ GONZALEZ BENIGNO. Secretario: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Datosregistrales. T 2882 , F 221, S 8, H Z 32651, I/A 15 (13.09.17).
19 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAR PEREZ PEDRO. Presidente: VILLAR PEREZ PEDRO. Consejero: HERRERO VELASCOJESUS;PANADES JAUREGUI JUAN JOSE;CARRERA CARRERA FERNANDO. Vicesecret.: HERRERO VELASCO JESUS.Consejero: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Secretario: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Cons.Del.Man: RIPOLL ROYOFERNANDO JOSE;HERRERO VELASCO JESUS. Nombramientos. Consejero: VILLAR PEREZ PEDRO. Presidente: VILLARPEREZ PEDRO. Consejero: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Secretario: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Consejero:HERRERO VELASCO JESUS. Vicesecret.: HERRERO VELASCO JESUS. Consejero: CARRERA CARRERA FERNANDO;PANADESVILLAR JON;VAZQUEZ GONZALEZ BENIGNO;CERCADILLO CRESPO MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man: HERRERO VELASCOJESUS;RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.800,00 Euros. Resultante Suscrito:78.200,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 7潞.- A.- La Junta General ser谩 convocada por los administradores y, en sucaso, por los liquidadores de la sociedad. B.- Los administradores convocar谩n la Junta General para su celebraci贸n dentro de los seisprimeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gesti贸n social, aproba. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩ginaweb corporativa: www.grupofyce.com. Datos registrales. T 2882 , F 220, S 8, H Z 32651, I/A 14 ( 8.10.15).
29 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GREGORI CARBI JOSEP;JIMENEZ CALONGE VICENTE. Datos registrales. T 2882 , F 220, S 8, HZ 32651, I/A 13 (20.11.13).
12 de Febrero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 86.600,00 Euros. Datos registrales. T 2882 , F 220,S 8, H Z 32651, I/A 12 ( 1.02.13).
03 de Septiembre de 2012Nombramientos. Auditor: TANA FARGAS JORDI. Aud.Supl.: DESPATX I GABINET D'AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2882 ,F 220, S 8, H Z 32651, I/A 11 (20.08.12).
23 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: VILLAR PEREZ PEDRO. Nombramientos. Cons.Del.Man: HERRERO VELASCO JESUS.Datos registrales. T 2882 , F 220, S 8, H Z 32651, I/A 10 (13.09.11).
02 de Marzo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 88.600,00 Euros. Datos registrales. T 2882 , F 220,S 8, H Z 32651, I/A 9 (21.02.11).
14 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GONZALEZ FERNANDEZ RAUL. Consejero: GONZALEZ FERNANDEZ RAUL;COTS TA脩A JUAN.Datos registrales. T 2882 , F 220, S 8, H Z 32651, I/A 8 ( 4.01.11).
22 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO. Secretario: DOMINGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO.Cons.Del.Man: DOMINGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO. Consejero: GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS. Nombramientos.Consejero: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE;JIMENEZ CALONGE VICENTE. Secretario: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE.Cons.Del.Man: RIPOLL ROYO FERNANDO JOSE. Datos registrales. T 2882 , F 219, S 8, H Z 32651, I/A 7 (11.06.09).