Actos BORME de G Mas C Hispalense Sl
28 de Noviembre de 2023Nombramientos. Vicepresid.: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Datos registrales. T 6694 , F 126, S 8, H SE55095, I/A 34 (17.11.23).
06 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Apo.Sol.: GALNARES GONZALEZ DE LAMADRID FRANCISCO. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DE LORENZO FRANCISCO JOSE;BARRIONUEVO POLO CARMEN;DIAZLORENTE ANTONIO;CANELO GOMEZ JORGE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DE LORENZO FRANCISCOJOSE;BARRIONUEVO POLO CARMEN;CANELO GOMEZ JORGE;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;DIAZLORENTE ANTONIO. Datos registrales. T 6694 , F 123, S 8, H SE 55095, I/A 33 (24.10.23).
28 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ CONDE JOSE. Datos registrales. T 6694 , F 123, S 8, H SE 55095, I/A 32 (20.09.23).
28 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: LIÑAN MACIAS DANIEL. Apo.Man.Soli: LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6694 , F 123, S8, H SE 55095, I/A 31 (19.12.22).
16 de Marzo de 2022Modificaciones estatutarias. 14. Funcionamiento Junta General.-. 20.3. Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración..Datos registrales. T 6694 , F 122, S 8, H SE 55095, I/A 30 ( 4.03.22).
20 de Enero de 2022Reelecciones. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6694 , F 122, S 8, H SE 55095,I/A 29 (13.01.22).
09 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido por la escrituraotorgada ante el Notario don José María Florit de Carranza el día 28 de marzo de 2019, número 797 de su protocolo, que motivó la ins23ª, incorporando como apoderado del Grupo 1 a DON JORGE CANELO GOMEZ con las facultades y límites de dicho Grupo 1.Datos registrales. T 6694 , F 121, S 8, H SE 55095, I/A 28 (19.08.21).
01 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido por la escrituraotorgada ante el Notario don José María Florit de Carranza el día 4 de diciembre de 2020, número 2.693 de protocolo, que motivó lains 26ª, incorporando a la misma como apoderado a DON JORGE CANELO GOMEZ con las facultades y límites que de ella resultan.Datos registrales. T 6694 , F 121, S 8, H SE 55095, I/A 27 (19.08.21).
04 de Enero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDE JOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATOVEGA LOURDES;LIÑAN MACIAS DANIEL. Nombramientos. Apo.Manc.: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDEJOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATO VEGA LOURDES;LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6694 , F 121,S 8, H SE 55095, I/A 26 (23.12.20).
01 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 6694 , F 121, S 8, H SE 55095, I/A25 (25.07.19).
25 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBSOFF BUENO SERGIO. Datos registrales. T 6694 , F 120, S 8, H SE 55095, I/A 24 (12.04.19).
23 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Datos registrales. T 6251 , F 214, S 8, H SE55095, I/A 22 ( 9.04.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LIÑAN MACIAS DANIEL;HERNANDEZ DE LORENZO FRANCISCO JOSE;BARRIONUEVO POLOCARMEN;DIAZ LORENTE ANTONIO. Datos registrales. T 6251 , F 217, S 8, H SE 55095, I/A 23 (10.04.19).
28 de Diciembre de 2018Nombramientos. Vsecr3.NC: DE LA CIERVA GALNARES INES. Modificaciones estatutarias. Modifica el apartado I del artículo20. Organo de administración-. Datos registrales. T 6251 , F 214, S 8, H SE 55095, I/A 21 (18.12.18).
18 de Diciembre de 2018Modificaciones estatutarias. 20. ORGANO DE ADMINISTRACION.-. Datos registrales. T 6251 , F 213, S 8, H SE 55095, I/A 20(11.12.18).
23 de Noviembre de 2018Reelecciones. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6251 , F 213, S 8, H SE 55095,I/A 19 (16.11.18).
22 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CIERVA GALNARES INES. SecreNoConsj: DE LA CIERVA GALNARES JUAN.Nombramientos. Consejero: DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Secretario: DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Datos registrales.T 6251 , F 212, S 8, H SE 55095, I/A 18 (15.12.17).
06 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDE JOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATOVEGA LOURDES;RUBSOFF BUENO SERGIO;LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6251 , F 212, S 8, H SE 55095, I/A 17(23.05.17).
18 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Datos registrales. T 5526 , F 26, S 8, H SE55095, I/A 16 (10.10.16).
13 de Octubre de 2016Revocaciones. Apoderado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID TERESA;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID MARIATERESA;MAS GALNARES MARIA CONSOLACION;DE LA CIERVA GALNARES INES. Datos registrales. T 5526 , F 26, S 8, H SE55095, I/A 15 ( 5.10.16).
05 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Secretario: DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Consejero:PEREZ DE AYALA MORENO SANTAMARIA MARIA TERESA ANTO. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LA CIERVA GALNARESJUAN. Vsecr1.NC: MAS GALNARES MIGUEL. Vsecr2.NC: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID LUIS. Consejero: DE LA CIERVAGALNARES INES;DE LA CIERVA GALNARES SILVIA;MAS GALNARES MARIA CONSOLACION;GALNARES GONZALEZ DE LAMADRID MARIA TERESA;RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL Datos registrales. T 3817 , F 178, S 8, H SE 55095, I/A 13(28.09.16).
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3817 ,F 178, S 8, H SE 55095, I/A 14 (28.09.16).
28 de Septiembre de 2016Fe de erratas: en la inscripcion 12ª, se inscribió por error como auditor a "AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR,S.L.", cuandosolo era AUDITOR DE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS. Datos registrales. T 3817 , F 177, S 8, H SE 55095, I/A 12 (30.08.16).
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 3817 , F 177, S 8, H SE 55095,I/A 12 (30.08.16).
12 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 3817 , F 177, S 8, H SE 55095, I/A12 (30.08.16).
05 de Agosto de 2014Reducción de capital. Importe reducción: 278.062,40 Euros. Resultante Suscrito: 8.265.256,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Datos registrales. T 3817 , F 176, S8, H SE 55095, I/A 11 (28.07.14).
15 de Noviembre de 2013Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 3817 , F 176, S 8, H SE 55095, I/A10 ( 5.11.13).
13 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL. Vicepresid.: RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL.
30 de Noviembre de 2012Reducción de capital. Importe reducción: 210.081,60 Euros. Resultante Suscrito: 8.543.318,40 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 3817 , F 174, S 8, H SE 55095, I/A 8 (13.11.12).