Actos BORME de G Z Construcciones E Inversiones Sa
18 de Agosto de 2022Reelecciones. Adm. Unico: GARCIA ZARANDIETA ANTONIO. Datos registrales. T 29542 , F 137, S 8, H M 76618, I/A 17(10.08.22).
24 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 29542 , F 135, S 8, H M76618, I/A 16 (17.12.20).
15 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA ZARANDIETA ANTONIO. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LAINSCRIPCION 15ª LA PUBLICACION DEL CESE DEL SECRETARIO NO CONSEJERO GARCIA ZARANDIETA ANTONIO. Datosregistrales. T 29542 , F 133, S 8, H M 76618, I/A 15 (21.10.16).
31 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ ARANCON MARIA DEL PILAR;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ ANTONIOJUAN;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. Presidente: GIMENEZ ARANCON MARIA DEL PILAR. Con.Delegado:GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA ZARANDIETA ANTONIO.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 8º, 9º, 13º, 14º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º Y 27 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradorúnico. Datos registrales. T 29542 , F 133, S 8, H M 76618, I/A 15 (21.10.16).
06 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ ARANCON MARIA DEL PILAR;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ ANTONIOJUAN;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. SecreNoConsj: GARCIA ZARANDIETA ANTONIO. Presidente:GIMENEZ ARANCON MARIA DEL PILAR. Con.Delegado: GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ ANTONIO JUAN. Nombramientos.SecreNoConsj: GARCIA ZARANDIETA ANTONIO. Consejero: GIMENEZ ARANCON MARIA DEL PILAR;GARCIA ZARANDIETAGIMENEZ ANTONIO JUAN;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. Presidente: GIMENEZ ARANCON MARIA DELPILAR. Con.Delegado: GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 29542 , F 132, S 8, H M 76618,I/A 14 (30.07.13).
11 de Marzo de 2013Ampliación de capital. Suscrito: 219.996,05 Euros. Desembolsado: 219.996,05 Euros. Resultante Suscrito: 388.276,05 Euros.Resultante Desembolsado: 388.276,05 Euros. Datos registrales. T 29542 , F 131, S 8, H M 76618, I/A 13 (28.02.13).
28 de Agosto de 2012Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-.Artículo de los estatutos: 3. Objeto.-.15. Convocatoria.Ampliacion del objeto social. LA PROMOCION, ORGANIZACION, ESTRUCTURACION, REORGANIZACION, ASESORAMIENTOYREALIZACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES... Cambio de domicilio social. C/ CEA BERMUDEZ 12 (MADRID). Datosregistrales. T 29542 , F 131, S 8, H M 76618, I/A 12 (14.08.12).
27 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: GARCIA ZARANDIETA JIMENEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 4660 , F 155, S 8, H M 76618,I/A 11 (15.02.12).
03 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR. Con.Delegado: GARCIA ZARANDIETAGIMENEZ MARIA DEL PILAR. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA ZARANDIETA ANTONIO. Con.Delegado: GARCIAZARANDIETA GIMENEZ ANTONIO JUAN. Reelecciones. Consejero: GIMENEZ ARANCON MARIA DEL PILAR;GARCIAZARANDIETA GIMENEZ MARIA DEL PILAR;GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ ANTONIO JUAN. Presidente: GIMENEZ ARANCONMARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 4660 , F 155, S 8, H M 76618, I/A 10 (19.04.10).