Buscador CIF Logo

Actos BORME Gabinete De Estudios Tecnicos Ingenieria Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gabinete De Estudios Tecnicos Ingenieria Sa

Actos BORME Gabinete De Estudios Tecnicos Ingenieria Sa - A28913218

Tenemos registrados 7 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gabinete De Estudios Tecnicos Ingenieria Sa con CIF A28913218

馃敊 Perfil de Gabinete De Estudios Tecnicos Ingenieria Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gabinete De Estudios Tecnicos Ingenieria Sa

01 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: POLONIO SANCHEZ LUIS MANUEL;LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA;CORTES FRIAS PA脩OSMARIA;GOMEZ GONZALEZ PEDRO;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO;LOSADABOSQUE ANGEL MARIA;GOMEZ GONZALEZ PEDRO;GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO;POLONIO SANCHEZ LUISMANUEL;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR;GOMEZ GONZALEZ PEDRO;LOSADA BOSQUEANGEL MARIA;GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO;GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL;LOSADA BOSQUE ANGELMARIA;GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR;POLONIOSANCHEZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 15833 , F 203, S 8, H M 29307, I/A 43 (25.05.22).

22 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL;LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA;SANCHEZ MATA MARIANOANTONIO;GONZALEZ ALVARO LUIS MARIANO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR. Datos registrales. T 15833 , F 202, S 8, H M29307, I/A 42 (15.02.22).

02 de Agosto de 2021
Reelecciones. Consejero: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL. Presidente: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL. Consejero:LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA. Secretario: LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA. Consejero: GONZALEZ ALVARO LUISMARIANO;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR Cambio de objeto social. LA COMPRA Y VENTAY ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES TANTO RUSTICOS COMO URBANOS. Datos registrales. T 15833 , F 201, S 8, H M29307, I/A 41 (26.07.21).

11 de Diciembre de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.219,34 Euros. Resultante Suscrito: 335.514,26 Euros. Datos registrales. T 15833 , F201, S 8, H M 29307, I/A 40 (29.11.19).

17 de Mayo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.375,60 Euros. Resultante Suscrito: 351.224,40 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 6.490,80 Euros. Resultante Suscrito: 344.733,60 Euros. Datos registrales. T 15833 , F 200, S 8, H M 29307, I/A 39 (9.05.16).

03 de Mayo de 2016
Reelecciones. Consejero: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL. Presidente: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL. Consejero:LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA. Secretario: LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA. Consejero: GONZALEZ ALVARO LUISMARIANO;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR Datos registrales. T 15833 , F 199, S 8, H M29307, I/A 38 (25.04.16).

15 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Consejero: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL. Presidente: GOMEZ GONZALEZ PEDRO DANIEL. Consejero:LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA. Secretario: LOSADA BOSQUE ANGEL MARIA. Consejero: GONZALEZ ALVARO LUISMARIANO;SANCHEZ MATA MARIANO ANTONIO;ZUBIAUR GONZALEZ CESAR Datos registrales. T 15833 , F 198, S 8, H M29307, I/A 37 ( 1.12.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n