Actos BORME de Gabinetes De Audioprotesis Electromedicina Y Servicios Sa
24 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ESCAYOLA MARANGES FERRAN. VsecrNoConsj: ARTIGAS GRAU ELENA. Consejero:FIORANI LORENZO;GALLI GABRIELE;VAN DER WEIDEN PAUL MARTINUS. Presidente: GALLI GABRIELE. Extinci贸n. Datosregistrales. T 4215 , F 38, S 8, H A 157319, I/A 14 (16.07.19).
23 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 4215 , F 37, S 8, H A 157319,I/A 12 (15.05.19).
22 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: VAN DER WEIDEN PAUL MARTINUS. Datos registrales. T 4075 , F 97, S 8, H A 157319, I/A 11(14.05.19).
03 de Abril de 2019Revocaciones. Auditor: FACSS AUDITORS SLP. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4075 , F97, S 8, H A 157319, I/A 10 (26.03.19).
25 de Marzo de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AMPLIFON SPA. Ceses/Dimisiones. Consejero: GASSBONA 2006 SL.Co.De.Ma.So: BOLTON XXI SL. Consejero: BOLTON XXI SL. Secretario: BOLTON XXI SL. Co.De.Ma.So: GASSBONA 2006 SL.Nombramientos. Consejero: FIORANI LORENZO;GALLI GABRIELE;VAN DER WEIDEN PAUL MARTINUS. Presidente: GALLIGABRIELE. SecreNoConsj: ESCAYOLA MARANGES FERRAN. VsecrNoConsj: ARTIGAS GRAU ELENA. Datos registrales. T 4075 ,F 96, S 8, H A 157319, I/A 9 (15.03.19).
19 de Marzo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.049,00 Euros. Resultante Suscrito: 332.112,00 Euros. Datos registrales. T 4075 , F 96,S 8, H A 157319, I/A 8 (11.03.19).
14 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RIPOLL NAVARRO FERNANDO. Datos registrales. T 4075 , F 96, S 8, H A 157319, I/A7 ( 6.02.19).
04 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ NAVARRO FRANCISCO;REMEDIOS MAXIMO MODESTO. Datos registrales. T4075 , F 96, S 8, H A 157319, I/A 6 (26.12.18).
24 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SANZ VAZQUEZ LUIS;JIMENEZ JUAN OLGA;FERNANDEZ NAVARRO FRANCISCO. Datosregistrales. T 4075 , F 96, S 8, H A 157319, I/A 5 (17.12.18).
07 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: FIORANI LORENZO. Datos registrales. T 4075 , F 94, S 8, H A 157319, I/A 4 (28.11.18).
20 de Febrero de 2018Nombramientos. Auditor: FACSS AUDITORS SLP. Datos registrales. T 4075 , F 94, S 8, H A 157319, I/A 3 (12.02.18).
16 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ ASTURIAS 2 (ALICANTE). Datos registrales. T 4075 , F 94, S 8, H A 157319, I/A 2 ( 8.11.17).
07 de Abril de 2017Revocaciones. CONSEJERO: PEREZ AUGUET SANTIAGO. CONS. DELEG.: PEREZ AUGUET SANTIAGO. SECRETARIO: PEREZAUGUET SANTIAGO. Nombramientos. CONSEJERO: GASSO NAVARRO JUAN. PRESIDENTE: GASSO NAVARRO JUAN.CONSEJERO: GASSBONA 2006 SL. CONS.DEL.M/S: GASSBONA 2006 SL. CONSEJERO: BOLTON XXI SL. SECRETARIO:BOLTON XXI SL. CONS.DEL.M/S: BOLTON XXI SL. REPR.143 RRM: GASSO NAVARRO ANTONIO;PEREZ AUGUET SANTIAGO.Datos registrales. T 39960 , F 223, S 8, H B 62708, I/A 53 (30.03.17).
27 de Enero de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: BALER INVER PLUS SL. Datos registrales. T 39960 , F 221, S 8, H B 62708, I/A 52(19.01.17).
10 de Febrero de 2016Revocaciones. CONSEJERO: ESPOY PEREZ JOSE MARIA. SECRETARIO: ESPOY PEREZ JOSE MARIA. Nombramientos.SECRETARIO: PEREZ AUGUET SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13,24,25 Y 27DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 39960 , F220, S 8, H B 62708, I/A 51 ( 3.02.16).
28 de Enero de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SLP. AUDT.CTS.CON: WIND AUDIT SLP. Datos registrales. T 39960 , F 220, S 8,H B 62708, I/A 50 (16.01.15).
28 de Agosto de 2012Nombramientos. CONSEJERO: ESPOY PEREZ JOSE MARIA. SECRETARIO: ESPOY PEREZ JOSE MARIA. CONSEJERO:GASSO NAVARRO JUAN. PRESIDENTE: GASSO NAVARRO JUAN. CONSEJERO: PEREZ AUGUET SANTIAGO. CONS. DELEG.:PEREZ AUGUET SANTIAGO. CONSEJERO: GASSBONA 2006 SL. CONS. DELEG.: GASSBONA 2006 SL. REPR.143 RRM: GASSONAVARRO ANTONIO. Datos registrales. T 39960 , F 217, S 8, H B 62708, I/A 49 (16.08.12).
26 de Enero de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SLP. Datos registrales. T 39960 , F 217, S 8, H B 62708, I/A 48 (16.01.12).
02 de Diciembre de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SLP. Datos registrales. T 39960 , F 216, S 8, H B 62708, I/A 47 (22.11.10).
29 de Octubre de 2010Nombramientos. APODERADO: FERNANDEZ NAVARRO FRANCISCO. Datos registrales. T 39960 , F 216, S 8, H B 62708, I/A 46(18.10.10).
26 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. ART.26.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DEADMINISTRADOR.Datos registrales. T 39960 , F 215, S 8, H B 62708, I/A 45 (12.03.10).
01 de Marzo de 2010Revocaciones. APODERADO: CHALER RODRIGUEZ AMABLE. Datos registrales. T 39960 , F 215, S 8, H B 62708, I/A 44(16.02.10).
03 de Febrero de 2010Revocaciones. CONSEJERO: CHALER RODRIGUEZ AMABLE. Datos registrales. T 39960 , F 215, S 8, H B 62708, I/A 43(22.01.10).
19 de Enero de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SLP. Datos registrales. T 39960 , F 215, S 8, H B 62708, I/A 42 ( 7.01.10).
02 de Enero de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SL. Datos registrales. T 39960 , F 214, S 8, H B 62708, I/A 41 (17.12.08).