Actos BORME de Gacomali Sl
01 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER;SIERRA MANTECON ANTONIO;BURGOS GOMEZANTONIO;SIERRA DOMINGUEZ MARIA ANGELES;FABRA BERNAL GUILLERMO;NARANJO CAMPO FRANCISCO. Presidente:GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: NARANJO CAMPO FRANCISCO. Secretario: GALLEGO DE FRANCISCO MARIAISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Reducción de capital. Importe reducción: 39.185,99 Euros.Resultante Suscrito: 5.889,92 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Artículo de losestatutos: 4. Domicilio social. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Otros conceptos: Renumeradas las participacionessociales del 1 al 196 ambos inclusive, modificando el articulo 5º de los Estatutos Sociales. Cambio del Organo de Administración:Consejo de administración a Administrador único. Cambio de domicilio social. C/ CANDIDO MATEOS 35 - PISO 8º C -28035MADRID- (MADRID). Cambio de objeto social. 1º.- Expolotación de cafés y bares, CNAE 5610.- 2º.- Comercio al por menor depescados y mariscos en establecimientos especializados. CNAE 4723. Datos registrales. T 29362 , F 62, S 8, H M 87394, I/A 10(24.06.21).
11 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Presidente: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Vicepresid.: GARCIAHOYO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: NARANJO CAMPO FRANCISCO. Presidente: GARCIA HOYOFRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: NARANJO CAMPO FRANCISCO. Apo.Manc.: GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER;NARANJOCAMPO FRANCISCO;BURGOS GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 29362 , F 61, S 8, H M 87394, I/A 9 ( 4.04.19).
17 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO. Presidente: GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO.Vicepresid.: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Secretario: GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Secretario:GALLEGO DE FRANCISCO MARIA ISABEL. Consejero: SIERRA DOMINGUEZ MARIA ANGELES;FABRA BERNAL GUILLERMO.Presidente: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Vicepresid.: GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 29362 , F 60, S 8,H M 87394, I/A 8 (10.08.15).
30 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: MARTINEZ GOMEZ FERNANDO. Consejero: MARTINEZ GOMEZ FERNANDO. Cons.Del.Sol:GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO. Consejero: GARCIA CALVO MANUEL. Secretario: BURGOS GOMEZ ANTONIO.Nombramientos. Consejero: GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER;SIERRA MANTECON ANTONIO. Vicepresid.: BURGOS GOMEZANTONIO. Secretario: GARCIA HOYO FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Reelecciones.Consejero: GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO;BURGOS GOMEZ ANTONIO. Presidente: GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 5333 , F 162, S 8, H M 87394, I/A 7 (20.12.11).
28 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ BURGOS ROSA. Secretario: GOMEZ BURGOS ROSA. Nombramientos. Consejero:BURGOS GOMEZ ANTONIO. Secretario: BURGOS GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5333 , F 162, S 8, H M 87394, I/A 6(16.07.10).