Actos BORME de Gadstrup V Sl
30 de Enero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41068 , F 150, S 8, H M 643274, I/A 8 (23.01.23).
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Adm. Unico: SONNEDIX ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 41068 , F 149, S 8, H M 643274, I/A 7 (15.12.22).
14 de Mayo de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SONNEDIX OMICRON SL. Datos registrales. T 41068 , F 149, S 8,H M 643274, I/A 6 ( 7.05.21).
26 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE;FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 41068 , F 148, S 8, H M 643274, I/A 5 (19.04.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NORMANN MARC. Nombramientos. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIAMASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID). Datosregistrales. T 41068 , F 148, S 8, H M 643274, I/A 4 (25.03.21).
26 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 13, S 8, H V 178601, I/A 7(18.06.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: GANDIA FORNES JOSE LUIS;VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUANPABLO. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 13, S 8, H V 178601, I/A 8 (18.06.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 13, S 8, H V 178601, I/A 9(18.06.20).
18 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: NORMANN MARC. Datosregistrales. T 10382, L 7663, F 13, S 8, H V 178601, I/A 6 ( 8.05.20).
05 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 13, S 8, H V 178601, I/A 4(26.10.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMAN KLAUS WILLY. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 13, S 8, H V178601, I/A 5 (26.10.18).
07 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: WICKE RICHARD. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 12, S 8, H V 178601, I/A 3 (31.08.18).
17 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFICINA 305 (ALFAFAR). Datos registrales. T 10382, L 7663, F12, S 8, H V 178601, I/A 2 ( 8.11.17).
27 de Abril de 2017Cambio de domicilio social. PASEO DE LA HABANA NUMERO 5, 1潞 DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 35800 , F 186, S8, H M 643274, I/A 2 (19.04.17).
10 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1210 , F 33, S 8, H L 24136, I/A 13 ( 3.03.17).
23 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN;LIEBEL CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GAARNLARSEN LARS CHRISTIAN. Otros conceptos: Art铆culo de los estatutos: 8. Organizaci贸n y de la administraci贸n de la sociedad.-.Datos registrales. T 1210 , F 31, S 8, H L 24136, I/A 10 (10.02.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 1210 , F 32, S 8, H L 24136, I/A 11 (10.02.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Manc.: WICKERICHARD;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1210 , F 32, S 8, H L 24136, I/A 12 (10.02.17).
15 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS;FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 1210 , F 30,S 8, H L 24136, I/A 8 ( 3.07.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMAN KLAUS WILLY. Datos registrales. T 1210 , F 31, S 8, H L 24136,I/A 9 ( 7.07.15).
01 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 1210 , F 29, S 8, H L 24136, I/A 6(21.07.14).
Nombramientos. Apoderado: NEXUS ENERGIA SA;NEXUS ENERGIA SA. Datos registrales. T 1210 , F 30, S 8, H L 24136, I/A 7(21.07.14).
18 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SEEM ERIC KRISTOFFER. Nombramientos. Adm. Solid.: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN.Datos registrales. T 1210 , F 29, S 8, H L 24136, I/A 5 (11.04.13).
14 de Agosto de 2012Otros conceptos: Se hace constar que el N.I.E. correcto del Administrador solidario, don Christian Liebel, es el Y0826700W, y no elY0286700W. Datos registrales. T 1210 , F 29, S 8, H L 24136, I/A 4 ( 2.08.12).
25 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PELLICER AMBERT JORDI;PINOS CRESPO FRANCESC. Nombramientos. Adm. Solid.: LIEBELCHRISTIAN;SEEM ERIC KRISTOFFER. Datos registrales. T 1210 , F 28, S 8, H L 24136, I/A 2 ( 8.10.10).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GREEN POWERS PARTNERS K/S. Datos registrales. T 1210 , F28, S 8, H L 24136, I/A 3 ( 8.10.10).
18 de Noviembre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.10.09. Objeto social: - Compraventa y explotaci贸n de instalaciones para la producci贸n deenerg铆ael茅ctrica a partir de fuentes renovables. - Compraventa, explotaci贸n y arrendamiento de fincas r煤sticas. - Servicios detransporte, almacenamiento y gesti贸n de toda clase de residuos. - Transformaci贸n y/o explotaci贸n de resid. Domicilio: C/ ACADEMIA23 BAJOS (MOLLERUSSA). Capital: 3.100,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ALTERNATIVA ENERGETICA3000 SL. Nombramientos. Adm. Solid.: PELLICER AMBERT JORDI;PINOS CRESPO FRANCESC. Datos registrales. T 1210 , F23, S 8, H L 24136, I/A 1 ( 9.11.09).