Actos BORME de Galafre Investments Sl
04 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD. Nombramientos. Apoderado: MARTINS CARLOS;DE SANTIAGOBONAFE ABIUD;FERNANDEZ-MARCOTE CASTRILLEJO MANUEL-CESAR. Datos registrales. T 38892 , F 196, S 8, H M 668674,I/A 13 (25.10.19).
28 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: AMIGO GOMEZ JOSE-LUIS;PEREZ CORRALES MARTA;MENENDEZ GALLEGO MONICA;MARTINJIMENEZ ANTONIO;ORTIZ BLANCO JOSE;GARRIDO DIAZ ALVARO. Apoderado: BERROZPE SANCHEZ JOSE CARLOS. Datosregistrales. T 38892 , F 195, S 8, H M 668674, I/A 12 (21.10.19).
25 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BERROZPE SANCHEZ CARLOS JOSE. Nombramientos. Consejero: MINNAERT MATHIEU.Vicepresid.: MINNAERT MATHIEU. Consejero: PERUYERO BLANCO RODRIGO. Vicesecret.: PERUYERO BLANCO RODRIGO.Consejero: MARTINS CARLOS. Datos registrales. T 38892 , F 195, S 8, H M 668674, I/A 11 (18.10.19).
10 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ACTIVOS SINGULARES HOTELEROS SL. Representan: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLOANTONIO. Nombramientos. Consejero: MABRY PATRICK THOMAS. Presidente: MABRY PATRICK THOMAS. Consejero: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO ANTONIO. Secretario: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLO ANTONIO. Consejero: BERROZPE SANCHEZCARLOS JOSE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 37510 , F 186, S 8, H M 668674, I/A 8 ( 3.06.19).
Nombramientos. Apoderado: DE SANTIAGO BONAFE ABIUD. Datos registrales. T 37510 , F 187, S 8, H M 668674, I/A 9 (3.06.19).
Nombramientos. Apoderado: BERROZPE SANCHEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 37510 , F 187, S 8, H M 668674, I/A 10 (3.06.19).
06 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ RAMOS JOSE. Nombramientos. Representan: GOMEZ-TEMBLEQUE ROMILLOANTONIO. Datos registrales. T 37510 , F 186, S 8, H M 668674, I/A 6 (27.02.19).
Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 54 (MADRID). Datos registrales. T 37510 , F 186, S 8, H M 668674, I/A 7 (27.02.19).
12 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN JIMENEZ ANTONIO;ORTIZ BLANCO JOSE;GARRIDO DIAZ ALVARO. Datos registrales. T37510 , F 183, S 8, H M 668674, I/A 5 ( 5.07.18).
11 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: AMIGO GOMEZ JOSE-LUIS;PEREZ CORRALES MARTA;MENENDEZ GALLEGO MONICA;BARREROMU脩OZ CAROLINA. Datos registrales. T 37510 , F 183, S 8, H M 668674, I/A 4 ( 4.07.18).
27 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: ACTIVOS SINGULARES HOTELEROS SL. Representan: PEREZ RAMOS JOSE. Cambio dedomicilio social. C/ EMISORA 20 (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 37510 , F 182, S 8, H M 668674, I/A 2(20.06.18).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ACTIVOS SINGULARES HOTELEROS SL. Datos registrales. T 37510 , F 182, S 8,H M 668674, I/A 3 (20.06.18).
19 de Abril de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 2.04.18. Objeto social: El asesoramiento y consultor铆a en general de toda clase deempresas, especialmente en los campos fiscal, contable, laboral, econ贸mico, multimedia, internet, servicios, en cuyo caso la sociedadactuar谩 como sociedad de medios o de intermediaci贸n. Domicilio: C/ MONTE ESQUINZA 30, BAJO IZQUIERDA (MADRID). Capital:3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Datos registrales. T 37510 , F 180, S 8, H M 668674, I/A 1 (12.04.18).