Actos BORME de Galaria Superficie Comercial Pamplona Sociedad Limitada
22 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: GARRIGUES CALDERON BELEN. Nombramientos. Representan: GARRIGUES CALDERONBELEN. Liquidador: TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 29379 , F 15, S8, H M 528785, I/A 10 (14.09.16).
22 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA131 1& (MADRID). Datos registrales. T 29379 , F 15, S 8, H M 528785, I/A 9 (11.12.15).
12 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: PARRIN DAVID;DROZD KRZYSZTOF;MCCANLES MARISSA;SU MELANIE;VANHAVERMAETSCOTT;SCHULER JODI;SKINNER JOHN. Nombramientos. Apoderado: ATKINSON RYAN DAVID. Datos registrales. T 29379 , F15, S 8, H M 528785, I/A 8 ( 3.11.14).
24 de Enero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: ARROYO CABALLERO ALFONSO;REVENGA MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 29379 , F 15, S8, H M 528785, I/A 7 (16.01.14).
22 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: RIBAS ESTEVA ANTONIO;GONGORA ALCAIDE JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 29379 , F 14,
01 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: ARROYO CABALLERO ALFONSO;REVENGA MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 29379 , F 13,S 8, H M 528785, I/A 5 (20.01.12).
31 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 250.573,00 Euros. Resultante Suscrito: 253.573,00 Euros. Datos registrales. T 29379 , F 12, S 8, HM 528785, I/A 4 (19.01.12).
20 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: PARRIN DAVID;GALLAHER TIMOTHY;BEUMER SUSAN;DROZD KRZYSZTOF;AHMEDAFRAZ;MCCANLES MARISSA;SU MELANIE;VANHAVERMAET SCOTT;SCHULER JODI;SKINNER JOHN. Datos registrales. T29379 , F 12, S 8, H M 528785, I/A 3 ( 9.01.12).