Actos BORME de Galeon Software Sl
21 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: GUIRADO USANOS BELEN. Apo.Sol.: GUIRADO USANOS BELEN. Datos registrales. T 39277 , F107, S 8, H M 312754, I/A 16 (13.03.23).
09 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: HORTELANO LOPEZ JAIME. Revocaciones. Apo.Sol.: HORTELANO LOPEZ JAIME.Nombramientos. Consejero: ANAYA REIG ALBERTO. Apo.Sol.: ANAYA REIG ALBERTO. Cambio de domicilio social. AVDA DEMANOTERAS 10 (MADRID). Datos registrales. T 39277 , F 105, S 8, H M 312754, I/A 15 (30.11.22).
07 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Como consecuencia del cambio de fecha de cierre del ejerciciosocial se modifica el artículo 3. Datos registrales. T 39277 , F 105, S 8, H M 312754, I/A 14 (30.09.22).
21 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MANTECON OSCAR. Datos registrales. T 39277 , F 104, S 8, H M 312754, I/A 13(14.03.22).
18 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: VILCHES DEL HOYO PEDRO ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: CUMPLIDO LOPEZ JOSELUIS;ALEMANY POZUELO DOLORES. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA JOSE JULIO. Datos registrales. T 39277 , F 104, S 8, H M312754, I/A 12 (11.02.22).
01 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING SL. Representan: HORTELANO LOPEZ JAIME.Nombramientos. SecreNoConsj: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA. Consejero: SPREAFICO OLIVIER DOMINIQUE JEAN;VILCHESDEL HOYO PEDRO ANTONIO;BOULANGER FRANCOIS;HORTELANO LOPEZ JAIME. Presidente: SPREAFICO OLIVIERDOMINIQUE JEAN. Apo.Sol.: HORTELANO LOPEZ JAIME. Modificaciones estatutarias. SE AÑADE UN NUEVO ARTICULO 13º
22 de Abril de 2021Declaración de unipersonalidad. Socio único: COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING SL. Datos registrales. T 39277 , F101, S 8, H M 312754, I/A 10 (15.04.21).
17 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. AVDA DE SAN LUIS 25 (MADRID). Datos registrales. T 18085 , F 129, S 8, H M 312754, I/A 9(10.10.19).
10 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GUIRADO USANOS BELEN. Datos registrales. T 18085 , F 126, S 8, H M 312754, I/A 7 ( 3.08.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA JOSE JULIO. Datos registrales. T 18085 , F 128, S 8, H M 312754, I/A 8 ( 3.08.18).
05 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: ALEMANY POZUELO DOLORES. Datos registrales. T 18085 , F 126, S 8, H M 312754, I/A 6
20 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: GUIRADO USANOS BELEN. Datos registrales. T 18085 , F 125, S 8, H M 312754, I/A 5 ( 7.08.12).
14 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CUMPLIDO LOPEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: COGNICASE MANAGEMENTCONSULTING SL. Representan: HORTELANO LOPEZ JAIME. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 5 DELOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de domicilio social. C/ CAMINO DE LAS CEUDAS 2 BIS - CARRETERA DE LA CO(ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T 18085 , F 124, S 8, H M 312754, I/A 3 ( 3.08.12).
Nombramientos. Apoderado: CUMPLIDO LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 18085 , F 125, S 8, H M 312754, I/A 4 (3.08.12).