Actos BORME de Galerias Primero Sa
18 de Agosto de 2010Otros conceptos: Cerrada la hoja por plazo provisional de seis meses, conforme al art铆culo 231 RRM. Datos registrales. T 3689 , F20, S 8, H Z 2760, I/A 58 F ( 9.08.10).
19 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: VILLEGAS RODRIGUEZ ALICIA. Datos registrales. T 3689 , F 20, S 8, H Z 2760, I/A 58 (10.02.10).
02 de Octubre de 2009Nombramientos. Apoderado: INIGO JIMENEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 3689 , F 19, S 8, H Z 2760, I/A 57 (23.09.09).
25 de Agosto de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: EIROA LAZARO EMILIO. Apo.Manc.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA;CANO SANCHEZLORENZO;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;LALAGUNA ARANDA AGUSTIN. Apo.Sol.: BERNAD POLO FERNANDO. Apo.Man.Soli:BERNAD POLO FERNANDO;PONTAQUE PONTAQUE JESUS. Apo.Manc.: CANO SANCHEZ LORENZO;TRUEBA CORTES JOSEMARIA;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Apo.Sol.: BERNAD POLOFERNANDO;PONTAQUE PONTAQUE JESUS;TRUEBA CORTES JOSE MARIA;CANO SANCHEZ LORENZO. Datos registrales. T3689 , F 19, S 8, H Z 2760, I/A 56 (14.08.09).
22 de Julio de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA.Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MILIAN JOSE LUIS;CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON.Presidente: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON. Con.Delegado: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DEARAGON. Consejero: MONTON MOLINA CARLOS;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;CANO SANCHEZ LORENZO;CAJA DEAHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRES. Vicepresid.: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLOEMPRES. Secretario: EIROA GARCIA EMILIO. Nombramientos. Adm. Solid.: PASCUAL SANSANO JUAN;REBOLLO MOZOSJUAN-CARLOS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoressolidarios.Art铆culo 26.- Estructura del Organo de Administraci贸n. 1. La sociedad estar谩 administrada por dos AdministradoresSolidarios. 2. La Junta General, por disposici贸n legal o estatutaria, podr谩 crear y nombrar los dem谩s cargos que estime convenientes.". Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z 2760, I/A 54 (13.07.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA FUENTE MARTINEZ GERARDO;FERRE脩O SANCHEZ JOSE-MANUEL;PARDO CASTROJOSE FERNANDO. Datos registrales. T 3689 , F 17, S 8, H Z 2760, I/A 55 (13.07.09).
03 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 16.999.987,86 Euros. Desembolsado: 16.999.987,86 Euros. Resultante Suscrito: 41.296.923,72Euros. Resultante Desembolsado: 41.296.923,72 Euros. Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z 2760, I/A 51 (25.05.09).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 16.814.755,93 Euros. Desembolsado: 16.814.755,93 Euros. Resultante Suscrito: 58.111.679,65Euros. Resultante Desembolsado: 58.111.679,65 Euros. Datos registrales. T 3689 , F 16, S 8, H Z 2760, I/A 52 (25.05.09).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON. Datos registrales. T3689 , F 16, S 8, H Z 2760, I/A 53 (25.05.09).
27 de Abril de 2009Nombramientos. Vicepresid.: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRES. Datos registrales. T 3689 , F16, S 8, H Z 2760, I/A 50 (16.04.09).
18 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Vicepresid.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA. Consejero:TRUEBA CORTES JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLOEMPRES. Datos registrales. T 3689 , F 15, S 8, H Z 2760, I/A 49 ( 9.03.09).
11 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: PONTAQUE PONTAQUE JESUS. Apoderado: LOSTAO ARGILES SANTIAGO-JOSE. Apo.Man.Soli:BERNAD POLO FERNANDO. Datos registrales. T 3689 , F 15, S 8, H Z 2760, I/A 47 ( 2.03.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA;CANO SANCHEZ LORENZO. Datos registrales. T 3689 , F 15, S 8, HZ 2760, I/A 48 ( 2.03.09).
16 de Febrero de 2009Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3356 , F 225, S 8, H Z 2760, I/A 45 ( 5.02.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: BERNAD POLO FERNANDO. Apo.Man.Soli: BERNAD POLO FERNANDO;PONTAQUE PONTAQUEJESUS. Apo.Manc.: CANO SANCHEZ LORENZO;TRUEBA CORTES JOSE MARIA;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;LALAGUNAARANDA JOSE AGUSTIN. Apo.Sol.: BERNAD POLO FERNANDO;PONTAQUE PONTAQUE JESUS. Datos registrales. T 3356 , F225, S 8, H Z 2760, I/A 46 ( 5.02.09).
12 de Febrero de 2009Nombramientos. Consejero: TRUEBA CORTES JOSE MARIA;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;CANO SANCHEZ LORENZO.Datos registrales. T 3356 , F 224, S 8, H Z 2760, I/A 42 ( 2.02.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPO TORRIJOS ANTONIO TOMAS;BURILLO ELHOMBRE JOSE MARIA. Vicepresid.:LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Nombramientos. Vicepresid.: TRUEBA CORTES JOSE MARIA. Apo.Manc.: TRUEBACORTES JOSE MARIA;CANO SANCHEZ LORENZO;GRACIA CONEJOS MARIA ROSA;LALAGUNA ARANDA AGUSTIN. Otrosconceptos: Se cambia el representante del consejero "Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag贸n" sustituyendo a Don Tom谩sGarc铆a Montes por Don Jos茅 Agust铆n Lalaguna Aranda. Datos registrales. T 3356 , F 224, S 8, H Z 2760, I/A 43 ( 2.02.09).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GARAY GOMEZ ENRIQUE. Consejero: GARAY GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3356 ,F 225, S 8, H Z 2760, I/A 44 ( 2.02.09).
10 de Febrero de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.682.833,88 Euros. Desembolsado: 1.682.833,88 Euros. Resultante Suscrito: 24.296.935,86 Euros.Resultante Desembolsado: 24.296.935,86 Euros. Datos registrales. T 3356 , F 224, S 8, H Z 2760, I/A 41 (30.01.09).