Actos BORME de Galicia Distribucion De Automoviles Sa
03 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: VAAMONDE LOUREIRO RICARDINA. Datos registrales. T 825 , F 154, S 8, H OR 5107, I/A 29(26.01.23).
28 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 825 , F 153, S 8, H OR 5107, I/A 28 (14.12.22).
30 de Septiembre de 2022Ampliacion del objeto social. El alquiler -excluido el arrendamiento financiero "leasing"- de autom贸viles sin conductor y elmantenimiento y gesti贸n de flotas de veh铆culos. Datos registrales. T 825 , F 153, S 8, H OR 5107, I/A 27 (16.09.22).
25 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDO JOAQUIN;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA.Presidente: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Con.Delegado: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE.Nombramientos. Consejero: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Presidente: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Con.Delegado: SEIJASPEREZ RAMON MARIA. Consejero: PEREZ BELLIDO JOAQUIN;PEREZ BELLIDO FARA. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE.
13 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: VAAMONDE LOUREIRO RICARDINA;ALVAREZ ULLA JOSE MARIANO. Apo.Sol.: VAAMONDELOUREIRO RICARDINA;ALVAREZ ULLA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 825 , F 152, S 8, H OR 5107, I/A 24 ( 5.09.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: VAAMONDE LOUREIRO RICARDINA. Apo.Sol.: VAAMONDE LOUREIRO RICARDINA. Apo.Manc.:VAZQUEZ LOPEZ VICTOR. Apo.Sol.: VAZQUEZ LOPEZ VICTOR. Apo.Manc.: QUIROGA VARELA DIEGO. Apo.Sol.: QUIROGAVARELA DIEGO. Datos registrales. T 825 , F 152, S 8, H OR 5107, I/A 25 ( 5.09.19).
10 de Octubre de 2017Reelecciones. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDO JOAQUIN;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Presidente:PEREZ NIETO JOSE RAMON. Con.Delegado: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE. Datosregistrales. T 825 , F 152, S 8, H OR 5107, I/A 23 (28.09.17).
06 de Julio de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: ANDRE CENDON EVANGELINA. Apo.Sol.: ANDRE CENDON EVANGELINA. Apo.Manc.: SANCHEZSENRA MARIA DEL CARMEN. Apo.Sol.: SANCHEZ SENRA MARIA DEL CARMEN. Apo.Manc.: ALVAREZ ULLA JOSE MARIANO.Apo.Sol.: ALVAREZ ULLA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 825 , F 151, S 8, H OR 5107, I/A 21 (25.06.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRE CENDON EVANGELINA. Apo.Manc.: VAAMONDE LOUREIRO RICARDINA;ALVAREZ ULLAJOSE MARIANO. Apo.Sol.: VAAMONDE LOUREIRO RICARDINA;ALVAREZ ULLA JOSE MARIANO. Datos registrales. T 825 , F151, S 8, H OR 5107, I/A 22 (25.06.15).
07 de Noviembre de 2012Reelecciones. Consejero: PEREZ NIETO JOSE RAMON;PEREZ BELLIDO JOAQUIN;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Presidente:PEREZ NIETO JOSE RAMON. Con.Delegado: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Secretario: SANTANA CARNERO IRENE. Datosregistrales. T 825 , F 151, S 8, H OR 5107, I/A 20 (26.10.12).
24 de Abril de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: ANDRE CENDON EVANGELINA;BORRAJO LORENZO MARISOL;SOTO IGLESIAS SUSANA. Apo.Sol.:ANDRE CENDON EVANGELINA;BORRAJO LORENZO MARISOL;SOTO IGLESIAS SUSANA. Datos registrales. T 378 , F 23, S 8,H OR 5107, I/A 19 ( 9.04.12).
19 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRE CENDON EVANGELINA;SANCHEZ SENRA MARIA DEL CARMEN;ALVAREZ ULLA JOSEMARIANOApo.Manc.: ANDRE CENDON EVANGELINA;SANCHEZ SENRA MARIA DEL CARMEN;ALVAREZ ULLA JOSE MARIANODatos registrales. T 378 , F 23, S 8, H OR 5107, I/A 18 ( 9.04.12).
22 de Julio de 2011Cambio de domicilio social. CTRA NACIONAL 120 S/N - QUINTELA (OURENSE). Datos registrales. T 378 , F 23, S 8, H OR5107, I/A 17 (11.07.11).
08 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDRE CENDON EVANGELINA;MARTINEZ COSTA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 378 , F22, S 8, H OR 5107, I/A 15 (24.02.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ANDRE CENDON EVANGELINA;BORRAJO LORENZO MARISOL;SOTO IGLESIAS SUSANA.Apo.Sol.: ANDRE CENDON EVANGELINA;BORRAJO LORENZO MARISOL;SOTO IGLESIAS SUSANA. Datos registrales. T 378 , F22, S 8, H OR 5107, I/A 16 (24.02.11).
24 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: ANDRE CENDON EVANGELINA. Datos registrales. T 378 , F 22, S 8, H OR 5107, I/A 14 (11.03.09).