Buscador CIF Logo

Actos BORME Galmotor Comercial Del Automovil Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Galmotor Comercial Del Automovil Sl

Actos BORME Galmotor Comercial Del Automovil Sl - B86243656

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Galmotor Comercial Del Automovil Sl con CIF B86243656

馃敊 Perfil de Galmotor Comercial Del Automovil Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Galmotor Comercial Del Automovil Sl

27 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SOLIS PAULA. Datos registrales. T 44001 , F 220, S 8, H M 521051, I/A 13 (19.12.23).

12 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BANIELLO IRMA;MENENDEZ VELASCO CONCEPCION;TADEO GARCIA SARA. Datosregistrales. T 28936 , F 153, S 8, H M 521051, I/A 12 ( 5.09.22).

23 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 28936 , F 153, S 8, H M 521051, I/A 11 (16.02.21).

15 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSOPURIFICACION. Datos registrales. T 28936 , F 153, S 8, H M 521051, I/A 10 ( 8.06.20).

24 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 28936 , F 153, S 8, H M 521051, I/A 9 (16.01.18).

18 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ ALONSO ROSA. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVOALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 550.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 650.000,00 Euros. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 28936 , F 152, S 8, H M 521051, I/A 8 ( 4.08.15).

03 de Agosto de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 40.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 28936 , F 152, S 8, HM 521051, I/A 7 (23.07.15).

13 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 28936 , F 151, S 8, H M 521051, I/A 6 (6.06.14).

06 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 28936 , F 150, S 8, H M 521051, I/A 5(23.02.12).

19 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALONSO PURIFICACION. Datos registrales. T 28936 , F 149, S 8, H M 521051, I/A 4 (6.10.11).

28 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: DE RODRIGO DE DIEGO JOSE MARIA. Datos registrales. T 28936 , F 148, S 8, H M 521051, I/A 2(15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ BEGO脩A;DE RODRIGO DE DIEGO JOSE MARIA. Datos registrales. T28936 , F 149, S 8, H M 521051, I/A 3 (15.09.11).

04 de Julio de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.06.11. Objeto social: COMPRAVENTA, REPARACION, MANTENIMIENTO,FABRICACION, ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, ASI COMO SUS PIEZAS,COMPONENTES, ACCESORIOS Y PRESUPUESTOS . . . Domicilio: C/ GENERAL ARRANDO 9 - DUPLICADO-BAJO (MADRID).Capital: 60.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ ALONSO ROSA. Datos registrales. T 28936 , F 146, S 8, H M521051, I/A 1 (21.06.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n