Actos BORME de Gam Centro Y Sur Sl
30 de Octubre de 2012Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3874 , F 117, S 8, H AS 41960, I/A 19 (18.10.12).
29 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3874 , F 117, S 8, H AS 41960, I/A17 ( 8.08.12).
21 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MORENO AZPILICUETA ANICETO. Datos registrales. T 3874 , F 117, S 8, H AS 41960, I/A 18 ( 8.08.12).
20 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: BERMUDEZ SANCHEZ MARIA ELSA;BERMUDEZ SANCHEZ MARIA ELSA;TRELLES SUAREZANTONIO. Apo.Sol.: TRELLES SUAREZ ANTONIO. Apoderado: FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO CARLOS. Datosregistrales. T 3874 , F 117, S 8, H AS 41960, I/A 16 ( 8.02.12).
29 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LOPEZ CARLOS. Datos registrales. T 3874 , F 117, S 8, H AS 41960, I/A 15 (18.11.11).
22 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: COBO ARAGONESES JOSE LUIS. Datos registrales. T 3874 , F 115, S 8, H AS 41960, I/A 10(11.11.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO AZPILICUETA ANICETO. Datos registrales. T 3874 , F 115, S 8, H AS 41960, I/A 11(11.11.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: BERMUDEZ SANCHEZ MARIA ELSA;TRELLES SUAREZ ANTONIO. Apo.Manc.: BERMUDEZ SANCHEZMARIA ELSA;TRELLES SUAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 3874 , F 115, S 8, H AS 41960, I/A 12 (11.11.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS ZAMORANO ANGEL. Datos registrales. T 3874 , F 116, S 8, H AS 41960, I/A 13 (11.11.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABRERA DEL OLMO JUAN IGNACIO;CABRERA DEL OLMO PABLO JAVIER. Apoderado:CABRERA FORNIELES TESIFONTE;FERNANDEZ PEREZ PEDRO LUIS;MU脩OZ BARAGA脩O ORENCIO;HERNANDEZ RUIGOMEZMARIO;FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO CARLOS. Apo.Sol.: CAMPILLO FERNANDEZ JOSE PABLO. Apo.Manc.:RODRIGUEZ FERNANDEZ ALVARO;FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID;CAMPILLO FERNANDEZ JOSE PABLO. Apoderado:MORENO AZPILICUETA ANICETO. Apo.Sol.: MORENO AZPILICUETA ANICETO;CABRERA DEL OLMO JUAN IGNACIO.Apoderado: HERNANDEZ RUIGOMEZ MARIO. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FERNANDEZ ALVARO;MORENO AZPILICUETAANICETO;CABRERA DEL OLMO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 3874 , F 116, S 8, H AS 41960, I/A 14 (11.11.11).
29 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO AZPILICUETA ANICETO. Apo.Manc.: MORENO AZPILICUETA ANICETO;TRELLES SUAREZANTONIO. Datos registrales. T 3874 , F 111, S 8, H AS 41960, I/A 5 (17.03.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: CABRERA DEL OLMO JUAN IGNACIO. Apo.Manc.: CABRERA DEL OLMO JUAN IGNACIO;TRELLESSUAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 3874 , F 112, S 8, H AS 41960, I/A 6 (17.03.11).
Nombramientos. Apoderado: BURGER DAVID. Datos registrales. T 3874 , F 112, S 8, H AS 41960, I/A 7 (17.03.11).
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ RUIGOMEZ MARIO. Datos registrales. T 3874 , F 113, S 8, H AS 41960, I/A 8(17.03.11).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO CARLOS. Datos registrales. T 3874 , F 113, S 8, H AS41960, I/A 9 (17.03.11).
25 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FERNANDEZ ALVARO;FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID;CAMPILLO FERNANDEZJOSE PABLO. Apo.Sol.: CAMPILLO FERNANDEZ JOSE PABLO. Datos registrales. T 3874 , F 111, S 8, H AS 41960, I/A 3(16.03.11).
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ BARAGA脩O ORENCIO. Datos registrales. T 3874 , F 111, S 8, H AS 41960, I/A 4(16.03.11).
08 de Febrero de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL ESPIRITUSANTO, CALLE DINAMARCA 1 (OVIEDO). Datos registrales. T 3874 , F 110, S 8, H AS 41960, I/A 2 (27.01.11).