Buscador CIF Logo

Actos BORME Ganaderia Especial Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ganaderia Especial Sl

Actos BORME Ganaderia Especial Sl - B78569167

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ganaderia Especial Sl con CIF B78569167

馃敊 Perfil de Ganaderia Especial Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ganaderia Especial Sl

31 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO. Secretario: RINCON JIMENEZ MOMEDIANOFRANCISCO. Revocaciones. Apoderado: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;RUIZ DE LA TORRE ESPORRINFRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: FRANCH ROMANI FRANCISCO. Datos registrales. T 26131 , F 119, S 8, H M69564, I/A 41 (24.05.23).

17 de Junio de 2020
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Cons.Del.Man: RUIZ JARABO TREVI脩O JESUS;RUIZ DE LA TORRE ESPORRINFRANCISCO. Datos registrales. T 26131 , F 118, S 8, H M 69564, I/A 39 m (10.06.20).

22 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 26131 , F 119, S 8, H M 69564, I/A 40 (14.11.17).

05 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Cons.Del.Man: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;RUIZ JARABO TREVI脩O JESUS. Datos registrales.T 26131 , F 118, S 8, H M 69564, I/A 39 (23.08.16).

04 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 0,20 Euros. Resultante Suscrito: 940.000,20 Euros. Ampliacion del objeto social. la compra, venta,explotaci贸n, cultivo, mejoramiento, de fincas r煤sticas, el cultivo, producci贸n, comercializaci贸n e industrializaci贸n de productos agr铆colasy ganaderos (CNAE 0150). 2. Las actividades forestales, administraci贸n y explotaci贸n de fincas forestales propias o arrendadas,incluyendo la. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DEHESA EL RINCON SL. ALCAYA SL. Datos registrales. T 26131 ,F 114, S 8, H M 69564, I/A 38 (28.01.16).

25 de Septiembre de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.664.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 940.000,00 Euros. Datos registrales. T 26131 ,F 113, S 8, H M 69564, I/A 37 (16.09.15).

31 de Marzo de 2015
Nombramientos. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 26131 , F 113, S 8, H M 69564, I/A 36 (23.03.15).

03 de Abril de 2014
Revocaciones. Apoderado: PRIETO URIZAR JAVIER. Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE LA TORRE ESPORRINFRANCISCO. Datos registrales. T 26131 , F 112, S 8, H M 69564, I/A 35 (27.03.14).

17 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ LARA GABRIEL;PEREZ DE LA VACAS TREJO MOISES. Datos registrales. T 26131 , F 112,S 8, H M 69564, I/A 34 ( 9.01.14).

05 de Enero de 2010
Nombramientos. Apoderado: PRIETO URIZAR JAVIER. Datos registrales. T 26131 , F 112, S 8, H M 69564, I/A 33 (22.12.09).

02 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MORA FIGUEROA DOMECQ SILVIA;GOMEZ TORRES GOMEZ TRENOR ALFREDO.Nombramientos. Consejero: MORA FIGUEROA Y DOMECQ SILVIA;NU脩EZ CERVERA JOSE JAVIER;GOMEZ TORRES NOGUESSONSOLES;RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;BOLINCHES GOMEZ TORRES FRANCISCO;RUIZ JARABO TREVI脩OJESUS;MORA FIGUEROA SERRA FERNANDO;MASAVEU MORA FIGUEROA CARLOS. Presidente: MORA FIGUEROA Y DOMECQSILVIA. Vicesecret.: MORA FIGUEROA SERRA FERNANDO. Con.Delegado: MORA FIGUEROA Y DOMECQ SILVIA. Cons.Del.Man:RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;RUIZ JARABO TREVI脩O JESUS. SecreNoConsj: RINCON JIMENEZ MOMEDIANOFRANCISCO. Apoderado: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 13911 , F 225, S 8, H M 69564, I/A 32(18.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n