Actos BORME de Ganaderia Especial Sl
31 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO. Secretario: RINCON JIMENEZ MOMEDIANOFRANCISCO. Revocaciones. Apoderado: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;RUIZ DE LA TORRE ESPORRINFRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: FRANCH ROMANI FRANCISCO. Datos registrales. T 26131 , F 119, S 8, H M69564, I/A 41 (24.05.23).
17 de Junio de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Cons.Del.Man: RUIZ JARABO TREVI脩O JESUS;RUIZ DE LA TORRE ESPORRINFRANCISCO. Datos registrales. T 26131 , F 118, S 8, H M 69564, I/A 39 m (10.06.20).
22 de Noviembre de 2017Revocaciones. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 26131 , F 119, S 8, H M 69564, I/A 40 (14.11.17).
05 de Septiembre de 2016Reelecciones. Cons.Del.Man: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;RUIZ JARABO TREVI脩O JESUS. Datos registrales.T 26131 , F 118, S 8, H M 69564, I/A 39 (23.08.16).
04 de Febrero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 0,20 Euros. Resultante Suscrito: 940.000,20 Euros. Ampliacion del objeto social. la compra, venta,explotaci贸n, cultivo, mejoramiento, de fincas r煤sticas, el cultivo, producci贸n, comercializaci贸n e industrializaci贸n de productos agr铆colasy ganaderos (CNAE 0150). 2. Las actividades forestales, administraci贸n y explotaci贸n de fincas forestales propias o arrendadas,incluyendo la. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DEHESA EL RINCON SL. ALCAYA SL. Datos registrales. T 26131 ,F 114, S 8, H M 69564, I/A 38 (28.01.16).
25 de Septiembre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.664.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 940.000,00 Euros. Datos registrales. T 26131 ,F 113, S 8, H M 69564, I/A 37 (16.09.15).
31 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 26131 , F 113, S 8, H M 69564, I/A 36 (23.03.15).
03 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: PRIETO URIZAR JAVIER. Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE LA TORRE ESPORRINFRANCISCO. Datos registrales. T 26131 , F 112, S 8, H M 69564, I/A 35 (27.03.14).
17 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ LARA GABRIEL;PEREZ DE LA VACAS TREJO MOISES. Datos registrales. T 26131 , F 112,S 8, H M 69564, I/A 34 ( 9.01.14).
05 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: PRIETO URIZAR JAVIER. Datos registrales. T 26131 , F 112, S 8, H M 69564, I/A 33 (22.12.09).
02 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MORA FIGUEROA DOMECQ SILVIA;GOMEZ TORRES GOMEZ TRENOR ALFREDO.Nombramientos. Consejero: MORA FIGUEROA Y DOMECQ SILVIA;NU脩EZ CERVERA JOSE JAVIER;GOMEZ TORRES NOGUESSONSOLES;RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;BOLINCHES GOMEZ TORRES FRANCISCO;RUIZ JARABO TREVI脩OJESUS;MORA FIGUEROA SERRA FERNANDO;MASAVEU MORA FIGUEROA CARLOS. Presidente: MORA FIGUEROA Y DOMECQSILVIA. Vicesecret.: MORA FIGUEROA SERRA FERNANDO. Con.Delegado: MORA FIGUEROA Y DOMECQ SILVIA. Cons.Del.Man:RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO;RUIZ JARABO TREVI脩O JESUS. SecreNoConsj: RINCON JIMENEZ MOMEDIANOFRANCISCO. Apoderado: RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN FRANCISCO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 13911 , F 225, S 8, H M 69564, I/A 32(18.02.09).