Actos BORME de Gascies Sl
20 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SALGADO SALGADO JAVIER. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 197, S 8, H PO 48814, I/A 13(12.04.23).
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ COSTA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 197, S 8, H PO 48814, I/A12 (12.04.23).
09 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA;PEREZ RUMBAO SA. Presidente: PEREZ RUMBAO SA.Con.Delegado: BUTAVIGO SA. Nombramientos. Consejero: PEREZ BELLIDO FARA. Presidente: PEREZ BELLIDO FARA.Con.Delegado: PEREZ BELLIDO FARA. Consejero: PEREZ RUMBAO SA. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 196, S 8, H PO48814, I/A 11 (31.08.22).
05 de Noviembre de 2020Reelecciones. Consejero: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA;PEREZ RUMBAO SA. Presidente: PEREZ RUMBAO SA. Vicepresid.:GASVIGO SL. Consejero: GASVIGO SL;BUTAVIGO SA. Con.Delegado: BUTAVIGO SA. Consejero: ALCANTARA MORALES JAVIER.Secretario: ALCANTARA MORALES JAVIER. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 195, S 8, H PO 48814, I/A 8 (28.10.20).
26 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: CASTRO CASTRO IAGO EMILIO. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 195, S 8, H PO 48814, I/A 7(18.11.19).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA. Apo.Manc.: SALGADO SALGADO JAVIER;DOMINGUEZSALGADO MIGUEL. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 195, S 8, H PO 48814, I/A 6 (25.08.17).
04 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCANTARA MORALES BELEN. Secretario: ALCANTARA MORALES BELEN. Nombramientos.Consejero: ALCANTARA MORALES JAVIER. Secretario: ALCANTARA MORALES JAVIER. Reelecciones. Consejero: SEIJASPEREZ RAMON MARIA;PEREZ RUMBAO SA. Presidente: PEREZ RUMBAO SA. Vicepresid.: GASVIGO SL. Consejero: GASVIGOSL;BUTAVIGO SA. Con.Delegado: BUTAVIGO SA. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 194, S 8, H PO 48814, I/A 5 (28.08.15).
20 de Enero de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 195.000,00 Euros. Datos registrales. T 3593, L3593, F 194, S 8, H PO 48814, I/A 4 (12.01.15).
21 de Julio de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 294.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Cambio de objeto social. ARTICULO2潞.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto: Realizaci贸n de labores de agencia en nombre y por cuenta de terceros en elsuministro domiciliario de G.L.P. envasado. El transporte de mercanc铆as por carretera, cualquier actividad de distribuci贸n a domicilio ycualquier otra que venga ausp. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 192, S 8, H PO 48814, I/A 3 ( 9.07.10).
31 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Datos registrales. T 3593, L 3593, F 192, S 8, H PO 48814, I/A 2(19.05.10).
05 de Enero de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.11.09. Objeto social: Realizaci贸n de labores de agencia en nombre y por cuenta de en elsuministro domiciliario de G.L.P. envasado. La actividad de distribuci贸n a domicilio y cualquier otra que venga auspiciada por Repsol.Domicilio: C/ SEVERINO COBAS 110 - LAVADORES (VIGO). Capital: 6.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: PEREZRUMBAO SA;GASVIGO SL;BUTAVIGO SA;ALCANTARA MORALES BELEN;SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Presidente: PEREZRUMBAO SA. Vicepresid.: GASVIGO SL. Secretario: ALCANTARA MORALES BELEN. Con.Delegado: BUTAVIGO SA. Datosregistrales. T 3593, L 3593, F 190, S 8, H PO 48814, I/A 1 (23.12.09).