Buscador CIF Logo

Actos BORME Gasoductos Y Redes Gisca Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gasoductos Y Redes Gisca Sa

Actos BORME Gasoductos Y Redes Gisca Sa - A28429777

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gasoductos Y Redes Gisca Sa con CIF A28429777

🔙 Perfil de Gasoductos Y Redes Gisca Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gasoductos Y Redes Gisca Sa

13 de Octubre de 2023
Reelecciones. Consejero: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA;GUY DE CHAMISSO BRUNO;ALVAREZ-CEDRON HERNANDEZANTONIO. Presidente: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Con.Delegado: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Datosregistrales. T 35601 , F 189, S 8, H M 12507, I/A 101 ( 5.10.23).

28 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PALAZON QUEVEDO ESTEBAN. Nombramientos. SecreNoConsj: CUESTA CASTIÑEYRARICARDO. Datos registrales. T 35601 , F 189, S 8, H M 12507, I/A 100 (21.06.22).

29 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: GALLEGO LOPEZ ARACELI. Apo.Man.Soli: VACAS GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 35601 , F187, S 8, H M 12507, I/A 97 (19.10.18).

Nombramientos. Apoderado: NIETO MORENO RUBEN. Datos registrales. T 35601 , F 187, S 8, H M 12507, I/A 98 (19.10.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIETO MORENO RUBEN. Datos registrales. T 35601 , F 188, S 8, H M 12507, I/A 99 (19.10.18).

25 de Octubre de 2018
Nombramientos. Con.Delegado: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 35601 , F 187, S 8, H M 12507, I/A 96(17.10.18).

05 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN ABELLA MANUEL;DURAND GILLES JEAN MICHEL. Con.Delegado: AGUIRREFERNANDEZ JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA;GUY DE CHAMISSOBRUNO;ALVAREZ-CEDRON HERNANDEZ ANTONIO. Presidente: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T35601 , F 186, S 8, H M 12507, I/A 95 (25.08.17).

02 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GALLEGO LOPEZ ARACELI. Nombramientos. SecreNoConsj: PALAZON QUEVEDOESTEBAN. Datos registrales. T 35601 , F 186, S 8, H M 12507, I/A 94 (26.07.17).

05 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Con.Delegado: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBARGONZALO. Presidente: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Nombramientos. Consejero: AGUIRRE FERNANDEZ JOSEMARIA. Con.Delegado: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Presidente: AGUIRRE FERNANDEZ JOSE MARIA. Reelecciones.Consejero: MARTIN ABELLA MANUEL;DURAND GILLES JEAN MICHEL;GUY DE CHAMISSO BRUNO;ALVAREZ-CEDRONHERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 13837 , F 113, S 8, H M 12507, I/A 93 (28.03.17).

29 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MUÑOZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ-CEDRON HERNANDEZANTONIO. Reelecciones. Consejero: MARTIN ABELLA MANUEL. Con.Delegado: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO.Presidente: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Consejero: DURAND GILLES JEAN MICHEL;GUY DE CHAMISSOBRUNO;GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO Datos registrales. T 13837 , F 113, S 8, H M 12507, I/A 92 (22.07.14).

03 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: ROSADO RODRIGUEZ PABLO. Apo.Manc.: ROSADO RODRIGUEZ PABLO. Apoderado: ROSADORODRIGUEZ PABLO. Otros conceptos: REVOCADO EL PODER A DON PABLO ROSADO RODRIGUEZ, OTORGADO MEDIANTEESCRITURA DE 16 DE JUNIO DE 2011, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 88.- Datos registrales. T 13837 , F 113, S 8, H M 12507,I/A 91 (21.11.12).

31 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VACAS GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 13837 , F 112, S 8, H M 12507, I/A 90 (22.10.12).

12 de Agosto de 2011
Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 6 (MADRID). Datos registrales. T 13837 , F 112, S 8, H M 12507, I/A 89 ( 2.08.11).

01 de Julio de 2011
Otros conceptos: SUSTITUIDAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PARRAFO 2.1 A FAVOR DE DON JAVIER MEDINAREUS CONFERIDAS EN ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 84& DE LA HOJA SOCIAL.- Datos registrales. T 13837 , F111, S 8, H M 12507, I/A 87 (20.06.11).

Otros conceptos: SUSTITUIDAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PARRAFO 2.1 A FAVOR DE DON PABLO ROSADORODRIGUEZ CONFERIDAS EN ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 76& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T13837 , F 111, S 8, H M 12507, I/A 88 (20.06.11).

26 de Abril de 2011
Revocaciones. Apoderado: MARIÑAS GOYANES BENITO. Datos registrales. T 13837 , F 111, S 8, H M 12507, I/A 86 (11.04.11).

06 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: ROSADO RODRIGUEZ PABLO. Datos registrales. T 13837 , F 110, S 8, H M 12507, I/A 85(23.09.10).

16 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ-BEATO DE COS MANUEL. Cons.Del.Sol: PEREZ-BEATO DE COS MANUEL. Presidente:PEREZ-BEATO DE COS MANUEL. Consejero: RODRIGUEZ PEREIRA JOSE. Nombramientos. Dir. General: MEDINA REUSFRANCISCO JAVIER. Consejero: ALVAREZ MUÑOZ MANUEL;MARTIN ABELLA MANUEL. Con.Delegado: GOMEZ ZAMALLOABARAIBAR GONZALO. Presidente: GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO. Reelecciones. Consejero: DURAND GILLES JEANMICHEL;GUY DE CHAMISSO BRUNO;GOMEZ ZAMALLOA BARAIBAR GONZALO Datos registrales. T 13837 , F 109, S 8, H M12507, I/A 84 ( 6.07.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información