Buscador CIF Logo

Actos BORME Gasomed Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gasomed Sl

Actos BORME Gasomed Sl - B59951988

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gasomed Sl con CIF B59951988

🔙 Perfil de Gasomed Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gasomed Sl

30 de Diciembre de 2022
Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ, NUMERO 10, 1ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36761 , F 205, S 8, H M658663, I/A 5 (22.12.22).

15 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GONZALEZ SALADICH LAURA;SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Consejero: SALADICH NEBOT JAVIER. Cons.Del.Man: GONZALEZ SALADICH LAURA;SALADICH MARTINEZ FRANCISCOJAVIER. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ SALADICH LAURA;SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Secretario:SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Ampliacion del objeto social. La generación y venta de energía eléctrica portransformación de la energía solar, y tanto fotovoltaica como térmica. Datos registrales. T 36761 , F 205, S 8, H M 658663, I/A 4 (7.10.21).

02 de Marzo de 2018
Otros conceptos: SUBSANADO ERROR PADECIDO EN EL TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL, SIENDO EL CORRECTO EL DELA CALLE VELAZQUEZ 53, 2ª PLANTA, DE MADRID. Datos registrales. T 36761 , F 205, S 8, H M 658663, I/A 3 (23.02.18).

18 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 43 (MADRID). Datos registrales. T 36761 , F 205, S 8, H M 658663, I/A 2 ( 9.12.17).

20 de Octubre de 2016
Ampliación de capital. Capital: 239.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.564.560,00 Euros. Datos registrales. T 23800 , F 64, S 8,H B 58899, I/A 12 (11.10.16).

12 de Enero de 2016
Revocaciones. CONS. DELEG.: SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. CONSEJERO: GONZALEZSALADICH LAURA. CONS. DELEG.: GONZALEZ SALADICH LAURA. CONSEJERO: SALADICH NEBOT BEATRIZ. CONS. DELEG.:SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 16: REQUISITOS PARA OSTENTAR LACONDICION DE ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 23800 , F 63, S 8, H B 58899, I/A 11 (31.12.15).

20 de Agosto de 2010
Modificaciones estatutarias. ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DEADMINISTRACION. Datos registrales. T 23800 , F 63, S 8, H B 58899, I/A 10 ( 9.08.10).

21 de Abril de 2010
Nombramientos. CONS. DELEG.: SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 23800 , F 62, S 8, H B 58899,I/A 9 ( 9.04.10).

28 de Julio de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: SALADICH CASTELLS MARCELO. PRESIDENTE: SALADICH CASTELLS MARCELO.SECRETARIO: MARTINEZ BALLESTER EMILIA. CONSEJERO: SALADICH MARTINEZ MARGARITA. CONS. DELEG.: SALADICHCASTELLS MARCELO. APODERADO: SALADICH MARTINEZ MARGARITA. Nombramientos. CONSEJERO: GONZALEZSALADICH JAVIER. PRESIDENTE: MARTINEZ BALLESTER EMILIA. SECRETARIO: SALADICH MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 23800 , F 62, S 8, H B 58899, I/A 8 (15.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información