Actos BORME de Gatamar Socimi Sa
16 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ DE BETHENCOURT CODES MANUEL. LiqSolid: VILAR TELLEZ ANTONIO;VILARMARQUES MARTA. Consejero: VILAR TELLEZ ANTONIO LUIS;VILAR MARQUES MARTA;HYRCHENKO MOLOCHKO OLGA.Presidente: VILAR TELLEZ ANTONIO LUIS. Cons.Del.Sol: VILAR MARQUES MARTA;VILAR TELLEZ ANTONIO LUIS. Vicepresid.:VILAR MARQUES MARTA. Nombramientos. LiqSolid: VILAR TELLEZ ANTONIO;VILAR MARQUES MARTA. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Liquidadores Solidarios. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n.Datos registrales. T 9841, L 7123, F 78, S 8, H V 161137, I/A 6 ( 9.03.17).
19 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: FIDES VILLALBA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9841, L 7123, F 78, S 8, H V 161137, I/A 5(12.01.15).
15 de Diciembre de 2014Nombramientos. Cons.Del.Sol: VILAR MARQUES MARTA;VILAR TELLEZ ANTONIO LUIS. Datos registrales. T 9841, L 7123, F77, S 8, H V 161137, I/A 3 ( 5.12.14).
Nombramientos. Vicepresid.: VILAR MARQUES MARTA. Datos registrales. T 9841, L 7123, F 77, S 8, H V 161137, I/A 4 ( 5.12.14).
01 de Septiembre de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.08.14. Objeto social: La sociedad tiene por objeto: a) La adquisici贸n y promoci贸n debienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de promoci贸n incluye la rehabilitaci贸n deedificaciones en los t茅rminos establecidos en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor A帽adido. b) La tenen. Domicilio: C/TRAFALGAR 52 Esc.1 9 A (VALENCIA). Capital suscrito: 60.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: VILAR TELLEZ ANTONIO LUIS;VILAR MARQUES MARTA;HYRCHENKO MOLOCHKO OLGA. Datos registrales. T9841, L 7123, F 74, S 8, H V 161137, I/A 1 (25.08.14).
Nombramientos. Presidente: VILAR TELLEZ ANTONIO LUIS. Secretario: RODRIGUEZ DE BETHENCOURT CODES MANUEL.Datos registrales. T 9841, L 7123, F 77, S 8, H V 161137, I/A 2 (25.08.14).