Buscador CIF Logo

Actos BORME Gbs Finanzas Investcapital A V Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gbs Finanzas Investcapital A V Sa

Actos BORME Gbs Finanzas Investcapital A V Sa - A83760249

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gbs Finanzas Investcapital A V Sa con CIF A83760249

馃敊 Perfil de Gbs Finanzas Investcapital A V Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gbs Finanzas Investcapital A V Sa

23 de Agosto de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 39734 , F 218, S 8, H M 336770, I/A 54 (16.08.23).

20 de Febrero de 2023
Otros conceptos: Deposito de proyecto de fusi贸n entre " GESALCALA S.G.I.I. SA" como Sociedad Asorbente y "GBS FINANZASIVESTCAPITAL AV SA" como Sociedad Absorbida. Datos registrales. T 19232 , F 56, S 8, H M 336770, I/A 1m (13.02.23).

23 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Auditor: ABALANCE AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESSL. Datos registrales. T 39734 , F 218, S 8, H M 336770, I/A 53 (16.11.22).

07 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BILBAO CALABUIG LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: BERNABE BARQUIN JESUS.VsecrNoConsj: GALLEGO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER. Cambio de domicilio social. C/ ORTEGA Y GASSET 7 (MADRID).Datos registrales. T 39734 , F 215, S 8, H M 336770, I/A 51 (31.05.22).

Revocaciones. Apoderado: BILBAO CALABUIG LUIS;GARCIA MATIAS JAVIER;BILBAO CALABUIG LUIS;VIAYNA CARDONAIGNACIO;ROLDAN LAZARO ADOLFO. Nombramientos. Apoderado: HAGERMAN ARNUS SANTIAGO;GUILLAUMES REGUEIRAALEIX;LUIS BILBAO CALABUIG. Datos registrales. T 39734 , F 216, S 8, H M 336770, I/A 52 (31.05.22).

08 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: GUILLAUMES REGUEIRA ALEIX. Datos registrales. T 39734 , F 214, S 8, H M 336770, I/A 50 (1.03.22).

02 de Marzo de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BANCO ALCALA SA. Datos registrales. T 39734 , F 213, S 8, H M 336770, I/A 47(23.02.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IVAN;GOMEZ DE BAEZA Y TINTURE PEDRO;HAGERMAN ARNUSSANTIAGO;ALONSO GONZALEZ JAIME;SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO. Vicepresid.: HAGERMAN ARNUS SANTIAGO.Cons.Del.Sol: HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Vicepresid.: ALONSO GONZALEZ JAIME. Presidente: SAMARANCH SALISACHSJUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL;GUILLAUMES REGUEIRA ALEIX;VIAYNACARDONA IGNACIO;ROLDAN LAZARO ADOLFO;SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO.Presidente: JORDA BLANES FRANCISCO MIGUEL. Datos registrales. T 39734 , F 213, S 8, H M 336770, I/A 48 (23.02.22).

Nombramientos. Apoderado: VIAYNA CARDONA IGNACIO;ROLDAN LAZARO ADOLFO. Datos registrales. T 39734 , F 213, S 8,H M 336770, I/A 49 (23.02.22).

24 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: JOVITA & JULES CAPITAL INVEST SL. Datos registrales. T 39734 , F 212, S 8, H M 336770, I/A 45(17.11.21).

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ MOREDA ANA;DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA. Datos registrales. T39734 , F 212, S 8, H M 336770, I/A 46 (17.11.21).

19 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO BARINGO PABLO;MU脩OZ BODAS SERGIO;OSORIO SUELVES BLANCA. Datos registrales.T 39734 , F 211, S 8, H M 336770, I/A 43 (12.11.21).

Nombramientos. Apoderado: BILBAO CALABUIG LUIS. Datos registrales. T 39734 , F 212, S 8, H M 336770, I/A 44 (12.11.21).

05 de Julio de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 20 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 39734 , F 211, S 8, H M336770, I/A 42 (28.06.21).

25 de Marzo de 2021
Cambio de objeto social. El desarrollo de las actividades permitidas a las Agencias de Valores, como empresas de servicios deinversi贸n, por el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre............ Datos registrales. T 39734 , F 211, S 8, H M 336770, I/A 41 (17.03.21).

16 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: JOVITA & JULES CAPITAL INVEST SL. Datos registrales. T 39734 , F 210, S 8, H M 336770, I/A 40 (9.03.21).

02 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA. Datos registrales. T 39734 , F 209, S 8, H M336770, I/A 35 (25.11.20).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATIAS JAVIER. Datos registrales. T 39734 , F 209, S 8, H M 336770, I/A 36 (25.11.20).

Nombramientos. Apoderado: ALASTRUE ARMENTIA JUAN JOSE. Datos registrales. T 39734 , F 209, S 8, H M 336770, I/A 37(25.11.20).

Nombramientos. Apoderado: AMAT PUIGSECH SERGIO. Datos registrales. T 39734 , F 210, S 8, H M 336770, I/A 38 (25.11.20).

Revocaciones. Apoderado: LORENZO MALVAR GERARDO. Datos registrales. T 39734 , F 210, S 8, H M 336770, I/A 39(25.11.20).

31 de Julio de 2020
Ampliacion del objeto social. A- La Sociedad tendr谩 como objeto social el desarrollo de las actividades permitidas a las Agencias deValores, como empresas de servicios de inversi贸n, por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley del Mercado de Valores y por el Real D. Datos registrales. T 39734 , F 208, S 8, H M 336770, I/A 34(24.07.20).

29 de Junio de 2020
Reelecciones. Auditor: ABALANCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 39734 , F 208, S 8, H M 336770, I/A 33 (22.06.20).

23 de Marzo de 2020
Cambio de objeto social. el desarrollo de las actividades permitidas a las Agencias de Valores, como empresas de servicios deinversi贸n, por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado deValores y por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre. Datos registrales. T 39734 , F 208, S 8, H M 336770, I/A 32(16.03.20).

20 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: LORENZO MALVAR GERARDO. Datos registrales. T 24946 , F 225, S 8, H M 336770, I/A 31(13.12.19).

12 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: ROLDAN NAVARRO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 24946 , F 225, S 8, H M 336770, I/A 30 (5.11.19).

16 de Abril de 2018
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 20潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCIONDE LOS ADMINISTRADORES.. Datos registrales. T 24946 , F 225, S 8, H M 336770, I/A 29 ( 6.04.18).

21 de Junio de 2017
Nombramientos. Auditor: ABALANCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 24946 , F 225, S 8, H M 336770, I/A 28 (13.06.17).

23 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ MOREDA ANA. Datos registrales. T 24946 , F 224, S 8, H M 336770, I/A 23 (10.03.17).

Nombramientos. Apoderado: ROLDAN NAVARRO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 24946 , F 224, S 8, H M 336770, I/A 24(10.03.17).

Nombramientos. Apoderado: MORENO GIRONA XAVIER. Datos registrales. T 24946 , F 224, S 8, H M 336770, I/A 25 (10.03.17).

Revocaciones. Apoderado: CASTILLO FRANCO ANA. Datos registrales. T 24946 , F 224, S 8, H M 336770, I/A 26 (10.03.17).

Revocaciones. Apoderado: ESQUER RUFILANCHAS JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 24946 , F 225, S 8, H M 336770, I/A27 (10.03.17).

07 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESQUER RUFILANCHAS JUAN. Vicepresid.: ESQUER RUFILANCHAS JUAN. Cons.Del.Sol:ESQUER RUFILANCHAS JUAN. Datos registrales. T 24946 , F 223, S 8, H M 336770, I/A 22 (24.02.17).

19 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apoderado: DE ESPEJO LABRADOR IVAN DOLZ. Datos registrales. T 24946 , F 223, S 8, H M 336770, I/A 21(11.08.16).

21 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO;ALONSO GONZALEZ JAIME;HAGERMAN ARNUSSANTIAGO;ESQUER RUFILANCHAS JUAN BAUTISTA;GOMEZ DE BAEZA Y TINTURE PEDRO;DIAZ LLADO PRADO PABLO.Presidente: SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO. Vicepresid.: ALONSO GONZALEZ JAIME;ESQUER RUFILANCHAS JUANBAUTISTA;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Cons.Del.Sol: ALONSO GONZALEZ JAIME;ESQUER RUFILANCHAS JUANBAUTISTA;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO;ALONSOGONZALEZ JAIME;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Presidente: SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO. Consejero: ESQUERRUFILANCHAS JUAN;GOMEZ DE BAEZA Y TINTURE PEDRO;DOLZ DE ESPEJO LABRADOR IVAN. Vicepresid.: ALONSOGONZALEZ JAIME;ESQUER RUFILANCHAS JUAN;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Cons.Del.Sol: ESQUER RUFILANCHASJUAN;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Reelecciones. SecreNoConsj: BILBAO CALABUIG LUIS. Modificaciones estatutarias.MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 24946 , F 222, S 8, H M 336770, I/A 20(13.07.16).

25 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: ABADIA GIMENO PABLO RAFAEL. Datos registrales. T 24946 , F 222, S 8, H M 336770, I/A 18(17.11.15).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ABADIA GIMENO PABLO RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: BILBAO CALABUIGLUIS. Datos registrales. T 24946 , F 222, S 8, H M 336770, I/A 19 (17.11.15).

03 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: BILBAO CALABUIG LUIS. Datos registrales. T 24946 , F 221, S 8, H M 336770, I/A 17 (26.10.15).

04 de Diciembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 15.790,00 Euros. Desembolsado: 15.790,00 Euros. Resultante Suscrito: 315.790,00 Euros.Resultante Desembolsado: 315.790,00 Euros. Datos registrales. T 24946 , F 220, S 8, H M 336770, I/A 16 (25.11.14).

06 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: CASTILLO FRANCO ANA. Datos registrales. T 24946 , F 220, S 8, H M 336770, I/A 15 (29.05.14).

19 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAMARANCH SALISACHS JUAN ANTONIO;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO;ALONSO GONZALEZJAIME;ESQUER RUFILANCHAS JUAN;GOMEZ DE BAEZA Y TINTURE PEDRO. Presidente: SAMARANCH SALISACHS JUANANTONIO. Vicepresid.: HAGERMAN ARNUS SANTIAGO;ALONSO GONZALEZ JAIME. Con.Delegado: ALONSO GONZALEZ JAIME.Vicepresid.: ESQUER RUFILANCHAS JUAN. Consejero: DIAZ LLADO PRADO PABLO. Nombramientos. Consejero: SAMARANCHSALISACHS JUAN ANTONIO;ALONSO GONZALEZ JAIME;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO;ESQUER RUFILANCHASJUAN;GOMEZ DE BAEZA Y TINTURE PEDRO;DIAZ LLADO PRADO PABLO. Presidente: SAMARANCH SALISACHS JUANANTONIO. Vicepresid.: ALONSO GONZALEZ JAIME;ESQUER RUFILANCHAS JUAN;HAGERMAN ARNUS SANTIAGO.

23 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: ESQUER RUFILANCHAS JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 24946 , F 217, S 8, H M 336770, I/A10 (11.11.11).

Nombramientos. Apoderado: ABADIA GIMENO PABLO RAFAEL. Datos registrales. T 24946 , F 217, S 8, H M 336770, I/A 11(11.11.11).

Nombramientos. Apoderado: DE ESPEJO LABRADOR IVAN DOLZ. Datos registrales. T 24946 , F 218, S 8, H M 336770, I/A 12(11.11.11).

Nombramientos. Apoderado: HAGERMAN ARNUS SANTIAGO. Datos registrales. T 24946 , F 218, S 8, H M 336770, I/A 13(11.11.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n