Actos BORME de Gco Reaseguros Sa
09 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36802 , F 101, S 8, H M 659054,I/A 8 ( 2.08.22).
14 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36802 , F 101, S 8, H M 659054,I/A 7 ( 7.09.21).
15 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: COTS PALTOR JORGE;DE SANTIAGO GOMEZ DAVID. Datos registrales. T 36802 , F 100, S 8, H M659054, I/A 6 ( 8.02.21).
29 de Enero de 2020Reelecciones. Adm. Unico: GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA. Representan: CLOSA CA脩ELLAS JUAN. Datos registrales. T36802 , F 100, S 8, H M 659054, I/A 5 (22.01.20).
02 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: PULPILLO LOPEZ JAVIER. Datos registrales. T 36802 , F 99, S 8, H M 659054, I/A 4 (25.06.19).
10 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36802 , F 99, S 8, H M 659054,I/A 3 ( 3.07.18).
21 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 4 (MADRID). Datos registrales. T 36802 , F 99, S 8, H M 659054, I/A 2(14.12.17).
28 de Agosto de 2017Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MADARIAGA PICAZA TERESA;PRADO PEREZ NOEMI;CAMP VIAPLANA ALBERT;BATISTACARRILLO ANTONIO. Datos registrales. T 44415 , F 96, S 8, H B 455461, I/A 10 (18.08.17).
28 de Junio de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44415 , F 96, S 8, H B 455461, I/A 9 (20.06.17).
21 de Abril de 2017Revocaciones. APODERAD.SOL: AYUSO EMA ENRIQUE. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: SOLE CARRERAS OSCAR. Datosregistrales. T 44415 , F 95, S 8, H B 455461, I/A 8 (11.04.17).
12 de Agosto de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: GONZALEZ BAILAC CARLOS FELIPE;GOMEZ BERMUDEZ CLARA. Datos registrales. T44415 , F 94, S 8, H B 455461, I/A 7 ( 3.08.16).
22 de Febrero de 2016Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.525.000,00 Euros. Datos registrales. T 44415 , F 94, S 8, H B 455461, I/A6 (11.02.16).
20 de Noviembre de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: AYUSO EMA ENRIQUE. Datos registrales. T 44415 , F 93, S 8, H B 455461, I/A 5 (12.11.15).
02 de Noviembre de 2015Nombramientos. APOD.SOL/MAN: NABAL VICU脩A ELENA;BIGORRA RODRIGUEZ CARLOS;PIDEVALL ALPISTE JUANMARIA;QUINTANA CARRE脩O MERCEDES. APODERAD.SOL: RIBES PRECKLER PEDRO;GUSILS GRAU CRISTINA. Datosregistrales. T 44415 , F 91, S 8, H B 455461, I/A 4 (23.10.15).
02 de Marzo de 2015Revocaciones. REPR.143 RRM: VILA TORTOSA JOSE. Nombramientos. REPR.143 RRM: CLOSA CA脩ELLAS JUAN. Datosregistrales. T 44415 , F 91, S 8, H B 455461, I/A 3 (18.02.15).
13 de Febrero de 2015Otros conceptos: ACREDITACION DEL INICIO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE2014. Datos registrales. T 44415 , F 89, S 8, H B 455461, I/A 1 N ( 5.02.15).
21 de Noviembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44415 , F 91, S 8, H B 455461, I/A 2 (13.11.14).
07 de Agosto de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: OBT.AUT.ADM.DIRECCION GEN. Objeto social: EXCLUSIVAMENTE EN REALIZAROPERACIONES DE REASEGURO EN GENERAL,EN TODOS LOS RAMOS DE SEGURO SIN LIMITACION DE AMBITOTERRITORIAL,CON SUJECCION A DISPOSICIONES PERTINENTES DE DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOSPENSIONES,ETC. Domicilio: AV ALCALDE BARNILS Num.63 (SANT CUGAT DEL VALLES). Capital suscrito: 9.050.000,00 Euros.Desembolsado: 4.525.000,00 Euros. Nombramientos. ADM.UNICO: GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA. REPR.143 RRM: VILATORTOSA JOSE. Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL UNICO SOCIO "GRUPOCATALANA OCCIDENTE,SA". Datos registrales. T 44415 , F 89, S 8, H B 455461, I/A 1 (31.07.14).