Actos BORME de Ge Healthcare Clinical Systems Sl
09 de Enero de 2013Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 27602 , F 82, S 8, H M 141932, I/A 64 (27.12.12).
13 de Julio de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.994.998,08 Euros. Resultante Suscrito: 15.145.248,08 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6潞. Capital.-. Datos registrales. T 27602 , F 82, S 8, H M 141932, I/A 63 ( 3.07.12).
11 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTIN BOADO ANA MARIA. VsecrNoConsj: SANZ FERRE ENRIQUE. Nombramientos.SecreNoConsj: SANZ FERRE ENRIQUE. VsecrNoConsj: DE LA VIUDA VILLANUEVA JIMENA. Datos registrales. T 27602 , F 81, S8, H M 141932, I/A 62 (30.05.12).
07 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTILLO ALONSO ALICIA. Nombramientos. Consejero: CAMPO CAMPOS LUIS. Datosregistrales. T 27602 , F 81, S 8, H M 141932, I/A 61 (23.02.12).
15 de Febrero de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27602 , F 81, S 8, H M 141932, I/A 60 ( 3.02.12).
31 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ MARTINEZ ANTONIO;CAMPO CAMPOS LUIS;HERRAEZ JIMENEZ JOSEANTONIO;TERRON LOPEZ MARIA DEL MAR. Apo.Man.Soli: CUEVAS BERLINCHES PEDRO. Datos registrales. T 27602 , F 79, S8, H M 141932, I/A 58 (19.01.12).
Revocaciones. Apoderado: SUAREZ RODRIGUEZ ISABEL;SAN MIGUEL VAL TOMAS;RODRIGUEZ GAMBOA ELENA;UCENDOESCABIAS RAQUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ MARTINEZ ANTONIO;SUAREZ RODRIGUEZ ISABEL;SAN MIGUEL VALTOMAS;RODRIGUEZ GAMBOA ELENA;CERRONI NICOLA;CAMPO CAMPOS LUIS;HERRAEZ JIMENEZ JOSEANTONIO;GRANADO GARCIA-BERNALT ALVARO;ALCANTARA AGU脩A ANTONIO;AGUILAR ADARVE JAVIER;GARAT PEREZLUIS-GONZAGA;MONTES POSADA AGUSTIN;DEL VALLE SILVA VICENTE;VALERIO GUIMERA JOSE IGNACIO;ROJAS TAMAYOMARIANO PABLO. Datos registrales. T 27602 , F 80, S 8, H M 141932, I/A 59 (19.01.12).
09 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: CAPELL ARRIETA ALMUDENA;CABANILLAS DE BARO ALFONSO;GEA BRUGADA MARIA;TERRONLOPEZ MARIA DEL MAR;CAMPO CAMPOS LUIS. Datos registrales. T 27602 , F 78, S 8, H M 141932, I/A 55 (28.12.11).
Nombramientos. Apoderado: CABANILLAS DE BARO ALFONSO;CAMPO CAMPOS LUIS;HERRAEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 27602 , F 79, S 8, H M 141932, I/A 56 (28.12.11).
Otros conceptos: Revocados la totalidad de los poderes conferidos a don Carlos Rubio Santos, en virtud de la escritura otorgada eld铆a 5de diciembre de 2005, con el n煤mero 4.118 de protocolo, queorigin贸 la inscripci贸n 20&. Datos registrales. T 27602 , F 79, S 8, HM 141932, I/A 57 (28.12.11).
25 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: SANTOS MONTES ESTHER. Datos registrales. T 27602 , F 78, S 8, H M 141932, I/A 53 (16.11.11).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RAMIREZ LUESMA VERONICA. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANZ FERRE ENRIQUE.Datos registrales. T 27602 , F 78, S 8, H M 141932, I/A 54 (16.11.11).
31 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 27602 , F 77, S 8, H M 141932, I/A 51 (19.08.11).
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANTOS MONTES MARIA ESTHER. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN BOADO ANAMARIA. VsecrNoConsj: RAMIREZ LUESMA VERONICA. Datos registrales. T 27602 , F 77, S 8, H M 141932, I/A 52 (19.08.11).
03 de Agosto de 2011Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: BREAS MEDICAL SL. Datos registrales. T 27602 , F 75, S 8, H M 141932, I/A 50(21.07.11).
10 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: SAENZ BASTERRA JIMENA;GONZALEZ ZAPATA FRANCISCO JOSE. Otros conceptos:Revocados los poderes concedidos a Do帽a Telva Arroyo Grejo,mediante escritura otorgada el d铆a 5 de diciembre de 2005, con eln煤mero 4118 de protocolo, que origin贸 la inscripci贸n 20&. Datos registrales. T 27602 , F 74, S 8, H M 141932, I/A 49 (30.05.11).
27 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: PEREZ MARTINEZ ANTONIO;ROJAS TAMAYO MARIANO PABLO;LOPEZ SANCHEZ ESCRIBANOALFONSO SANTOS;AGUILAR GONZALEZ-BABE FEDERICO;ARROYO CREJO TELVA;RUBIO SANTOS CARLOS. Datosregistrales. T 27602 , F 74, S 8, H M 141932, I/A 48 (12.04.11).
12 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: AGUILAR GONZALEZ-BABE FEDERICO;LOZOYA SERRANO JULIAN;SANTOS LOPEZ SANCHEZESCRIBANO ALFONSO. Apo.Sol.: AGUILAR GONZALEZ-BABE FEDERICO. Datos registrales. T 27602 , F 73, S 8, H M 141932, I/A47 (30.03.11).
12 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: MI脩AMBRES ALVAREZ ANGEL. Apo.Sol.: DE LA FUENTE BARBA ELENA. Datos registrales. T 27602, F 73, S 8, H M 141932, I/A 45 (31.12.10).
Nombramientos. Apoderado: LUIS MIRANDA RUBI. Datos registrales. T 27602 , F 73, S 8, H M 141932, I/A 46 (31.12.10).
17 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27602 , F 72, S 8, H M 141932, I/A 44 ( 5.11.10).
10 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTO LINARES DANIEL. Nombramientos. Consejero: MIRANDA RUBI LUIS. Datos registrales. T27602 , F 72, S 8, H M 141932, I/A 43 (27.10.10).
20 de Agosto de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ OROSA MARIA JOSEFA. Datos registrales. T 27602 , F 71, S 8, H M 141932, I/A 42 (5.08.10).
15 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: TERRON LOPEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 27602 , F 71, S 8, H M 141932, I/A 41 (4.06.10).
05 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: GOMEZ SELLES GARATE JAVIER MARIA. Datos registrales. T 21715 , F 225, S 8, H M 141932, I/A40 (26.04.10).
03 de Mayo de 2010Revocaciones. Apoderado: PETRONIN CHRISTIAN;RODRIGUEZ MATE ANTONIO;GRAU VIDAL ANA;ESLAVA SILLAS MIGUELANGEL. Apo.Sol.: DEL COSO SANCHEZ MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: MARTIN BOADO ANA MARIA. Datos registrales.T 21715 , F 225, S 8, H M 141932, I/A 39 (21.04.10).
14 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21715 , F 225, S 8, H M 141932, I/A 38 ( 1.12.09).
09 de Diciembre de 2009Otros conceptos: SUBSANADO EL ERROR COMETIDO AL DECIR EL NUEVO DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EN LAINSCRIPCION 36& DE ESTA HOJA, SIENDO EL CORRECTO: CALLE GOBELAS, NUMERO 35-37, LA FLORIDA, 28023-MADRID.Datos registrales. T 21715 , F 225, S 8, H M 141932, I/A 37 (26.11.09).
27 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. C/ GOBELAS 35-37 - EL PLANTIO (MADRID). Datos registrales. T 21715 , F 224, S 8, H M 141932,I/A 36 (17.11.09).
17 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: DEL COSO SANCHEZ MIGUEL;DE LA FUENTE BARBA ELENA. Datos registrales. T 21715 , F 224, S8, H M 141932, I/A 35 ( 4.09.09).
30 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PIFARRE FABREGAT CRISTINA BELEN. Nombramientos. Consejero: SOTO LINARES DANIEL.Datos registrales. T 21715 , F 224, S 8, H M 141932, I/A 34 (21.07.09).