Buscador CIF Logo

Actos BORME Ge Sensing & Inspection Iberica Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ge Sensing & Inspection Iberica Sl

Actos BORME Ge Sensing & Inspection Iberica Sl - B81968794

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ge Sensing & Inspection Iberica Sl con CIF B81968794

馃敊 Perfil de Ge Sensing & Inspection Iberica Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ge Sensing & Inspection Iberica Sl

20 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANZ FERRE ENRIQUE. Consejero: DUASO ANSO GABRIEL. Presidente: DUASO ANSOGABRIEL. Consejero: REQUENA SILLA ELVIRA;LOZOYA SERRANO JULIAN. Secretario: LOZOYA SERRANO JULIAN. Disoluci贸n.Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 28863 , F 179, S 8, H M 220198, I/A 23 (10.04.12).

26 de Marzo de 2012
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPA脩A SA. Datosregistrales. T 28863 , F 179, S 8, H M 220198, I/A 22 (13.03.12).

15 de Diciembre de 2011
Otros conceptos: SE RECTIFICA EL ERROR CONTENIDO EN LOS PUNTOS 2.9 Y 3.9 DELPROYECTO DE ESCISION-FUSIONQUE ORIGINO LA ANOTACION MARGINAL 1-M. Datos registrales. T 13544 , F 1, S 8, H M 220198, I/A 1M (29.11.11).

14 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: VALERA Y MARTOS ENRIQUE. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANZ FERRE ENRIQUE. Datosregistrales. T 13544 , F 225, S 8, H M 220198, I/A 18 ( 5.07.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ MARTIN MARTA. Nombramientos. Consejero: REQUENA SILLA ELVIRA. Datosregistrales. T 13544 , F 225, S 8, H M 220198, I/A 19 ( 5.07.11).

Cambio de domicilio social. C/ GOBELAS 35-37 (MADRID). Datos registrales. T 13544 , F 225, S 8, H M 220198, I/A 20 ( 5.07.11).

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MARTIN MARTA. Nombramientos. Apoderado: REQUENA SILLA ELVIRA. Datosregistrales. T 28863 , F 179, S 8, H M 220198, I/A 21 ( 5.07.11).

13 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: VARRIALE GENNARO;VALLET ROMAIN. Secretario: VALLET ROMAIN. Revocaciones.Apoderado: VARRIALE GENNARO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ MARTIN MARTA;LOZOYA SERRANO JULIAN.Secretario: LOZOYA SERRANO JULIAN. Datos registrales. T 13544 , F 225, S 8, H M 220198, I/A 17 ( 4.07.11).

28 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOTSFORD PAUL. Secretario: BOTSFORD PAUL. Revocaciones. Apoderado: LOZOYASERRANO JULIAN;MARTIN TOBES CARMEN;LOPEZ SANCHEZ ESCRIBANO ALFONSO SANTOS;DIEZ MONTEMAYORORLANDO;DE MIGUEL GOMEZ ERNESTO. Nombramientos. Consejero: VARRIALE GENNARO. Secretario: VALLET ROMAIN.Apoderado: VARRIALE GENNARO;VALLET ROMAIN;DUASO ANSO GABRIEL;LOZOYA SERRANO JULIAN;SANTOS LOPEZESCRIBANO ALFONSO;DE MIGUEL GOMEZ ERNESTO;MARTIN TOBES CARMEN MARIA;CORTAZAR VIDAURALVARO;SOTILLO ALONSO ALICIA;DE EUSEBIO GOMEZ PEDRO. Datos registrales. T 13544 , F 223, S 8, H M 220198, I/A 16(16.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n