Actos BORME de Geasur Sa
27 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DE LORENZO FRANCISCO JOSE;BARRIONUEVO POLO CARMEN;DIAZ LORENTEANTONIO;CANELO GOMEZ JORGE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DE LORENZO FRANCISCOJOSE;BARRIONUEVO POLO CARMEN;CANELO GOMEZ JORGE;DIAZ LORENTE ANTONIO. Datos registrales. T 6378 , F 30, S 8,H SE 15053, I/A 38 (19.10.23).
28 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ CONDE JOSE. Datos registrales. T 6378 , F 30, S 8, H SE 15053, I/A 37 (20.09.23).
28 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: LIÑAN MACIAS DANIEL. Apoderado: LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6378 , F 30, S 8,H SE 15053, I/A 35 (19.12.22).
04 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE CRISTOBAL GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 6378 , F 29, S 8, H SE 15053, I/A 34(27.07.22).
10 de Mayo de 2022Declaración de unipersonalidad. Socio único: GRUPO SYRSA AUTOMOVILES S.L. Reducción de capital. Importe reducción:4.375,84 Euros. Resultante Suscrito: 57.706,39 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 2.305,13 Euros. Desembolsado: 2.305,13Euros. Resultante Suscrito: 60.011,52 Euros. Resultante Desembolsado: 60.011,52 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo delos estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6378 , F 29, S 8, H SE 15053, I/A 33 (28.04.22).
01 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido por la escrituraotorgada ante el Notario don José María Florit de Carranza el día 4 de diciembre de 2020, número 2.694 de protocolo, que motivó lains 30ª, incorporando a la misma como apoderado a DON JORGE CANELO GOMEZ con las facultades y límites que de ella resultan.Datos registrales. T 6378 , F 27, S 8, H SE 15053, I/A 31 (18.08.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido por la escrituraotorgada ante el Notario don José María Florit de Carranza el día 28 de marzo de 2019, número 800 de su protocolo, que motivó la ins29ª, incorporando como apoderado del Grupo 1 a DON JORGE CANELO GOMEZ con las facultades y límites de dicho Grupo 1.Datos registrales. T 6378 , F 28, S 8, H SE 15053, I/A 32 (18.08.21).
04 de Enero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDE JOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATOVEGA LOURDES;LIÑAN MACIAS DANIEL. Nombramientos. Apo.Manc.: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDEJOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATO VEGA LOURDES. Datos registrales. T 6378 , F 27, S 8, H SE 15053, I/A 30(23.12.20).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: LIÑAN MACIAS DANIEL;HERNANDEZ DE LORENZO FRANCISCO JOSE;BARRIONUEVO POLOCARMEN;DIAZ LORENTE ANTONIO;DE CRISTOBAL GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 6378 , F 24, S 8, H SE 15053, I/A 29(29.04.19).
25 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBSOFF BUENO SERGIO. Datos registrales. T 6378 , F 23, S 8, H SE 15053, I/A 28 (12.04.19).
11 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: G MAS CHISPALENSE SL. Datos registrales. T 6378 , F 23, S 8, H SE 15053, I/A 27 ( 3.08.17).
30 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDE JOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATOVEGA LOURDES;RUBSOFF BUENO SERGIO;LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6378 , F 23, S 8, H SE 15053, I/A 26(23.05.17).
24 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: MESEGUER MARTINEZ JOAQUIN. Apo.Sol.: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID MARIATERESA;DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Datos registrales. T 3249 , F 216, S 8, H SE 15053, I/A 25 (17.04.17).
11 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRIDFRANCISCO. Consejero: GALNARES FERNANDEZ MANUEL;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;DE LA CIERVAGALNARES JUAN. Presidente: GALNARES FERNANDEZ MANUEL. Secretario: DE LA CIERVA GALNARES JUAN.Nombramientos. Adm. Unico: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Modificaciones estatutarias. MODIFICALOS ARTICULOS 7 , 8 Y 11 DE SUS ESTATUTOS SOCIALES, Y SUPRIME Y DEJA SIN CONTENIDO EL ARTICULO 10º DE LOSMISMOS.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datosregistrales. T 3249 , F 215, S 8, H SE 15053, I/A 23 (27.11.15).
Modificaciones estatutarias. 9. RETRIBUCION CARGO DE ADMINISTRADOR.- . Datos registrales. T 3249 , F 215, S 8, H SE15053, I/A 24 (27.11.15).
09 de Octubre de 2013Modificaciones estatutarias. 12. Conovocatoria de la Junta General..12. Bis. Junta General.-. Datos registrales. T 3249 , F 215, S8, H SE 15053, I/A 22 ( 1.10.13).
30 de Octubre de 2012Reelecciones. Consejero: GALNARES FERNANDEZ MANUEL;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;CIERVAGALNARES JUAN DE LA. Presidente: GALNARES FERNANDEZ MANUEL. Secretario: CIERVA GALNARES JUAN DE LA. Datosregistrales. T 3249 , F 214, S 8, H SE 15053, I/A 20 (19.10.12).
Nombramientos. Con.Delegado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Datos registrales. T 3249 , F 215, S 8, HSE 15053, I/A 21 (19.10.12).