Actos BORME de Geida Tlemcen Sl
24 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GAYAN CONTERO EMMANUEL. Nombramientos. Consejero: DEL CORRAL BERAZA JULEN.Datos registrales. T 29074 , F 207, S 8, H M 410236, I/A 37 (17.08.23).
09 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: ESTEBAN GUITARD DAVID;COLON LASSO DE LA VEGA CARLOS;JALON GONZALEZ EVA;LEMESDE LEON RAUL. Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN GUITARD DAVID;COLON LASSO DE LA VEGA CARLOS;JALON
08 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 29074 , F 205, S 8, H M 410236, I/A 35 ( 1.02.23).
13 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: LEMES DE LEON RAUL. Nombramientos. Representan: DIAZ DE ESPADA SEBASTIANAURORA. Datos registrales. T 29074 , F 205, S 8, H M 410236, I/A 34 ( 5.01.23).
12 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 29074 , F 205, S 8, H M 410236, I/A 33 ( 3.11.21).
13 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: COLON LASSO DE LA VEGA CARLOS. Revocaciones. Apo.Manc.: COLON LASSO DE LAVEGA CARLOS;ESTEBAN GUITARD DAVID;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO.Nombramientos. SecreNoConsj: HERRERA CASQUETE DE PRADO JERONIMO. Apo.Manc.: ESTEBAN GUITARD DAVID;COLONLASSO DE LA VEGA CARLOS;JALON GONZALEZ EVA;LEMES DE LEON RAUL. Datos registrales. T 29074 , F 204, S 8, H M410236, I/A 32 ( 6.09.21).
08 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: LEMES DE LEONRAUL. Datos registrales. T 29074 , F 203, S 8, H M 410236, I/A 31 (30.03.21).
16 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 29074 , F 203, S 8, H M 410236, I/A 30 ( 9.03.21).
03 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Presidente:MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYRCONCESIONES PARTICIPADAS III SL. Presidente: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS III SL. Representan: JALONGONZALEZ EVA;MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 29074 , F 202, S 8, H M 410236, I/A 29 (24.02.21).
15 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: ESTEBAN GUITARD DAVID;COLON LASSO DE LA VEGA CARLOS;DORADO GARCIAANTONIO;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO. Nombramientos. Apo.Manc.: COLON LASSO DE LA VEGACARLOS;ESTEBAN GUITARD DAVID;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 29074 , F 200, S 8, H M 410236, I/A 28 ( 8.03.19).
29 de Noviembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 209.366,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.463.226,00 Euros. Datos registrales. T 29074 ,F 200, S 8, H M 410236, I/A 27 (22.11.18).
08 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 29074 , F 200, S 8, H M 410236, I/A 26 ( 1.10.18).
15 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DORADO GARCIA ANTONIO. Presidente: DORADO GARCIA ANTONIO. Nombramientos.Consejero: MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Presidente: MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T29074 , F 200, S 8, H M 410236, I/A 25 ( 6.02.18).
06 de Octubre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 962.874,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.672.592,00 Euros. Datos registrales. T 29074 ,F 125, S 8, H M 410236, I/A 24 (28.09.17).
20 de Febrero de 2017Otros conceptos: Se subsana el error al consignar las participaciones, en escritura que caus贸 la inscripci贸n 21陋 de la hoja de lasociedad. Datos registrales. T 29074 , F 123, S 8, H M 410236, I/A 22 (10.02.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MANSILLA SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: GAYAN CONTERO EMMANUEL.Datos registrales. T 29074 , F 125, S 8, H M 410236, I/A 23 (10.02.17).
02 de Diciembre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.524.616,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.635.466,00 Euros. Datos registrales. T29074 , F 123, S 8, H M 410236, I/A 21 (22.11.16).
21 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: COSIN FERNANDEZ CARLOS;MARTINEZ MANSILLA SANTIAGO;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZPABLO;DORADO GARCIA ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: ESTEBAN GUITARD DAVID;COLON LASSO DE LA VEGACARLOS;DORADO GARCIA ANTONIO;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO. Datos registrales. T 29074 , F 120, S 8, H M410236, I/A 19 (13.10.16).
Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO SILVELA, 42, 4陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 29074 , F 121, S 8, H M410236, I/A 20 (13.10.16).
25 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: COSIN FERNANDEZ CARLOS. SecreNoConsj: MAULEON LOZANO SANTOS. Nombramientos.Consejero: ESTEBAN GUITARD DAVID. SecreNoConsj: COLON LASSO DE LA VEGA CARLOS. Datos registrales. T 29074 , F 120,S 8, H M 410236, I/A 18 (17.05.16).
14 de Octubre de 2015Reelecciones. Consejero: COSIN FERNANDEZ CARLOS;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;DORADO GARCIA ANTONIO.
13 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ SERRANO RAMON;SANCHEZ VEGA JOSE ANTONIO;FERNANDEZ DE PIEROLA JOAQUIN.Apo.Man.Soli: MORENO DIAZ ERNESTO. Apo.Manc.: DIAZ BATANERO JUAN PABLO;GONZALEZ WIEDMAIERCRISTOBAL;JIMENEZ SERRANO RAMON;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;SANCHEZ VEGA JOSE ANTONIO;COSINFERNANDEZ CARLOS;FERNANDEZ DE PIEROLA MARIN JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Manc.: COSIN FERNANDEZCARLOS;MARTINEZ MANSILLA SANTIAGO;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;DORADO GARCIA ANTONIO. Datosregistrales. T 29074 , F 118, S 8, H M 410236, I/A 16 ( 2.10.15).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ ALONSO AIDA. Nombramientos. SecreNoConsj: MAULEON LOZANO SANTOS.Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 43 (MADRID). Datos registrales. T 29074 , F 119, S 8, H M 410236, I/A17 ( 2.10.15).
28 de Junio de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.160.082,00 Euros. Datos registrales. T 29074 , F 117,S 8, H M 410236, I/A 14 (18.06.12).
23 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FONTANALS DE MIGUEL BELEN. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ ALONSO AIDA.Cambio de domicilio social. C/ OMBU 3 - PLANTA 3& (MADRID). Datos registrales. T 29074 , F 116, S 8, H M 410236, I/A 13(11.05.12).
15 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: PEREZ ALONSO AIDA. Consejero: FERNANDEZ DE PIEROLA MARIN JOAQUIN. Nombramientos.SecreNoConsj: FONTANALS DE MIGUEL BELEN. Consejero: MARTINEZ MANSILLA SANTIAGO. Datos registrales. T 29074 , F116, S 8, H M 410236, I/A 12 ( 2.12.11).
07 de Diciembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 801.402,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.416.082,00 Euros. Datos registrales. T 22904 , F 139, S8, H M 410236, I/A 10 (23.11.10).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.624.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.040.082,00 Euros. Modificaciones estatutarias.MODIFICADOS LOS ARTICULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 22904 , F 140, S 8, H M410236, I/A 11 (24.11.10).
22 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ VEGA JOSE ANTONIO. Presidente: SANCHEZ VEGA JOSE ANTONIO.Nombramientos. Consejero: DORADO GARCIA ANTONIO. Presidente: DORADO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 22904 ,F 138, S 8, H M 410236, I/A 9 ( 6.10.10).
17 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.351.580,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.614.680,00 Euros. Datos registrales. T 22904 , F 138,S 8, H M 410236, I/A 8 ( 2.03.10).
24 de Febrero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.260.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.263.100,00 Euros. Datos registrales. T 22904 , F 137,S 8, H M 410236, I/A 7 (12.02.09).