Actos BORME de Genaq Technologies Sl
29 de Noviembre de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 280.000,00 Euros. Datos registrales. T 2584 , F 118, S 8, HCO 38107, I/A 6 (18.11.22).
21 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ALVAREZ AURELIO. Presidente: GARCIA ALVAREZ AURELIO. Consejero: PASCUALCABILLAS ALBERTO JOSE. Vicesecret.: PASCUAL CABILLAS ALBERTO JOSE. Consejero: RAYA PORTERO JOSEMARIA;TORRES TENLLADO JOSE;CANO CAVANILLAS JAVIER;BLANCO LUQUE ANTONIO. Con.Delegado: RAYA PORTEROJOSE MARIA. Secretario: PASCUAL CABILLAS ALBERTO JOSE. Nombramientos. Consejero: GARCIA ALVAREZ AURELIO.Presidente: GARCIA ALVAREZ AURELIO. Consejero: TORRES TENLLADO JOSE. Vicepresid.: TORRES TENLLADO JOSE.Consejero: RAYA PORTERO JOSE MARIA. Con.Delegado: RAYA PORTERO JOSE MARIA. Consejero: PASCUAL CABILLASALBERTO JOSE. Secretario: PASCUAL CABILLAS ALBERTO JOSE. Consejero: RAMOS PEREZ ANGEL MARIA. Vicesecret.:RAMOS PEREZ ANGEL MARIA. Consejero: BLANCO LUQUE ANTONIO;CANO CABANILLAS JAVIER;GARCIA BLAZQUEZCARLOS;SALAS AIZPURU JAVIER. Datos registrales. T 2584 , F 118, S 8, H CO 38107, I/A 5 (14.04.21).
24 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ARPA AZOFRA CLARA;MARCELLAN ALBACAR DANIEL;BUJEDA RAMI TOMAS. Vicepresid.: ARPAAZOFRA CLARA. Secretario: MARCELLAN ALBACAR DANIEL. Nombramientos. Secretario: PASCUAL CABILLAS ALBERTOJOSE. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 80.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. 24. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 2584 , F 117, S 8, H CO 38107, I/A 4(16.09.20).
21 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA BLAZQUEZ CARLOS. Datos registrales. T 2577 , F 168, S 8, H CO 38107, I/A 3 (13.02.18).
02 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 90.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 2577 , F 167, S 8, HCO 38107, I/A 2 (22.01.18).
06 de Junio de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.05.17. Objeto social: Objeto La Sociedad tiene por objeto el dise帽o, investigaci贸n ydesarrollo, constituci贸n de patentes, fabricaci贸n y comercializaci贸n de bienes de equipo relacionados con las tecnolog铆as de agua ocualquier equipo de tecnolog铆a de transferencia t茅rmica de cualquier tipo. -C.N.A.E. 3299- La Sociedad po. Domicilio: BULEV LOSSANTOS 34 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS SANT (LUCENA). Capital: 10.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GARCIAALVAREZ AURELIO. Presidente: GARCIA ALVAREZ AURELIO. Consejero: ARPA AZOFRA CLARA. Vicepresid.: ARPA AZOFRACLARA. Consejero: MARCELLAN ALBACAR DANIEL. Secretario: MARCELLAN ALBACAR DANIEL. Consejero: PASCUAL CABILLASALBERTO JOSE. Vicesecret.: PASCUAL CABILLAS ALBERTO JOSE. Consejero: RAYA PORTERO JOSE MARIA;TORRESTENLLADO JOSE;BUJEDA RAMI TOMAS;CANO CAVANILLAS JAVIER;BLANCO LUQUE ANTONIO. Con.Delegado: RAYAPORTERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 2577 , F 161, S 8, H CO 38107, I/A 1 (30.05.17).