Actos BORME de Gener Eolica Sl
02 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Nombramientos. Liquidador: ZAPICO GARCIA ANA MARIA.Disoluci贸n. Otras Causas. Extinci贸n. Datos registrales. T 3825 , F 214, S 8, H AS 40641, I/A 4 (16.07.13).
26 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Presidente: MARTINEZ ZAPICO SATURNINO. Consejero:MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO;REDONDO BLAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: MARTINEZ ESPINAR JOSEIGNACIO. Revocaciones. Secretario: ZAPICO GARCIA ANA MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ ZAPICOSATURNINO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 3825 , F 214, S 8, H AS 40641, I/A 3 (16.05.11).
10 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 1. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ PALACIO VALDES 1 3潞 -DERECHA (OVIEDO). Datos registrales. T 3825 , F 213, S 8, H AS 40641, I/A 2 (22.01.10).
28 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: REDONDO BLAZQUEZFRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: MARTINEZ ESPINAR JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1077 , F 181, S 8, H LE 16922, I/A5 (16.12.09).
13 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO CARRACEDO FELIPE. Vicepresid.: RUBIO CARRACEDO FELIPE. Cons.Del.Man: RUBIOCARRACEDO FELIPE. Datos registrales. T 1077 , F 180, S 8, H LE 16922, I/A 4 ( 4.08.09).
15 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.100,00 Euros. Datos registrales. T 1077 , F 180, S 8, H LE16922, I/A 3 ( 2.04.09).