Actos BORME de Generacion Iberia Sl
10 de Enero de 2023Cambio de domicilio social. CL ELECTRONICA Num.19 P.7 PTA.C (BADALONA). Datos registrales. T 46978 , F 173, S 8, H B537089, I/A 25 (30.12.22).
05 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: QUEROL RODRIGUEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 34115 , F 44, S 8, H M 370869, I/A 20(28.08.18).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA GARCIA ATILANO. Datos registrales. T 34115 , F 43, S 8, H M 370869, I/A 19 (6.03.17).
11 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Auditor: ALBADIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34115 , F 43, S 8, H M 370869, I/A 18 (31.10.16).
17 de Octubre de 2016Cambio de domicilio social. C/ ADOLFO PEREZ ESQUIVEL 3, OFICINA 12, PLANTA 1ª (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 34115 , F 43, S 8, H M 370869, I/A 17 (23.09.16).
05 de Agosto de 2016Declaración de unipersonalidad. Socio único: AUDAX ENERGIA SA. Datos registrales. T 34115 , F 42, S 8, H M 370869, I/A 16(28.07.16).
23 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: QUEROL RODRIGUEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 34115 , F 42, S 8, H M 370869, I/A 15(13.05.16).
19 de Mayo de 2016Nombramientos. Auditor: ALBADIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34115 , F 42, S 8, H M 370869, I/A 14 (10.05.16).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANS MARIA ROSA. Datos registrales. T 34115 , F 41, S 8, H M 370869, I/A 13(10.02.16).
17 de Diciembre de 2015Cambio de domicilio social. C/ PADRE JESUS ORDOÑEZ 18 - 1º IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 20919 , F 79, S 8,H M 370869, I/A 10 (10.12.15).
Nombramientos. Apoderado: ROMEU BARCELO EDUARDO. Datos registrales. T 20919 , F 79, S 8, H M 370869, I/A 11(10.12.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ ANTUÑA ALBERTO;GONZALVEZ HERNANDEZ FRANCISCO;GONZALEZ SANS MARIAROSA. Datos registrales. T 34115 , F 40, S 8, H M 370869, I/A 12 (10.12.15).
29 de Enero de 2015Ampliación de capital. Capital: 183.490,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Datos registrales. T 20919 , F 78, S 8, HM 370869, I/A 9 (22.01.15).
16 de Diciembre de 2014Pérdida del caracter de unipersonalidad. Cambio de domicilio social. CTRA DE FUENCARRAL 44 - CAMPUS EMPRESARIALTRIBECA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 20919 , F 78, S 8, H M 370869, I/A 8 ( 5.12.14).
09 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALVEZ HERNANDEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: GONZALEZ SANS MARIA ROSA. Datosregistrales. T 20919 , F 77, S 8, H M 370869, I/A 7 ( 1.12.14).
07 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: GONZALVEZ HERNANDEZ FRANCISCO;GONZALEZ SANS MARIA ROSA. Datos registrales. T20919 , F 76, S 8, H M 370869, I/A 6 (30.09.14).
25 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ABOLLADO BRIS JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 20919 , F 75, S 8, H M 370869, I/A 5(18.09.14).
22 de Julio de 2014Declaración de unipersonalidad. Socio único: AUDAX ENERGIA SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABOLLADO BRIS JUANANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: BARRIOS NAVARRO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 20919 , F 75, S 8, H M370869, I/A 4 (14.07.14).
10 de Junio de 2009Ampliación de capital. Capital: 13.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 16.510,00 Euros. Datos registrales. T 20919 , F 74, S 8, H M370869, I/A 3 (29.05.09).