Actos BORME de General De Analisis Materiales Y Servicios Sociedad Limitada
20 de Septiembre de 2023Cambio de objeto social. a) La realizaci贸n de an谩lisis, ensayos y control para el tratamiento y calidad de las aguas. b) Lacoordinaci贸n en la realizaci贸n de estudios referentes a la calidad y tratamiento de las aguas. c) La realizaci贸n de pruebas, ensayos ylimpieza de las instalaciones de abastecimientos, saneamiento y de. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 217, S 8, H V 36096, I/A54 (13.09.23).
04 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MARQUES ALONSO ALFREDO;RODRIGUEZ FORTIS HECTOR. Nombramientos. Apo.Sol.: AYZAPRATS MANUEL;RODRIGUEZ FORTIS HECTOR. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 217, S 8, H V 36096, I/A 52 (28.12.22).
13 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: MICO ALBUIXECH SOFIA. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 216, S 8, H V 36096, I/A 51 (6.07.22).
01 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO.Datos registrales. T 10897, L 8175, F 215, S 8, H V 36096, I/A 49 (25.03.22).
Revocaciones. Apoderado: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: MAESTRE PICON JUANFRANCISCO. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 216, S 8, H V 36096, I/A 50 (25.03.22).
18 de Noviembre de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 215, S 8, H V 36096, I/A 48 (11.11.21).
26 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: BONET DOMINGO EMILIO. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 215, S 8, H V 36096, I/A 47(19.02.21).
18 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. C/ DEL CORRETGER 51 (PATERNA). Datos registrales. T 10897, L 8175, F 215, S 8, H V 36096, I/A46 (11.02.21).
19 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 88, S 8, H V 36096, I/A42 (12.01.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MICO JUAN JOSE;MELCHOR IBA脩EZ AGUSTIN;PEREZ PALOMAR JUANJOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MICO JUAN JOSE;MELCHOR IBA脩EZAGUSTIN;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE;MACIAN CERVERA JAVIER. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 88, S 8, H V 36096,I/A 43 (12.01.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO.Nombramientos. Apo.Sol.: MACIAN CERVERA JAVIER;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO. Datosregistrales. T 10897, L 8175, F 214, S 8, H V 36096, I/A 44 (12.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: CLAVEL PADRO JOSE MARIA;SANCHIS LLEDO FERNANDO JOSE;LASERNA GUZMANSOLEDAD;CHAFER MI脩ANA REMEDIOS. Datos registrales. T 10897, L 8175, F 214, S 8, H V 36096, I/A 45 (12.01.21).
05 de Noviembre de 2020Cambio de objeto social. "Articulo 2..-La sociedad tiene por objeto: El objeto social lo constituye: a) La realizaci贸n de an谩lisis,ensayos y control para el tratamiento y calidad de las aguas. b) La coordinaci贸n en la realizaci贸n de estudios referentes a la calidad ytratamiento de las aguas. c) La realizaci贸n de pruebas,. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 87, S 8, H V 36096, I/A 41 (28.10.20).
08 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ MICO JUAN JOSE;SANCHEZ MOLINO ENRIQUE;PEREZ PALOMAR JUANJOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE;RAMOS APARICI SEVERINO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MICO JUANJOSE;MELCHOR IBA脩EZ AGUSTIN;PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE. Datos registrales. T 5611,L 2918, F 86, S 8, H V 36096, I/A 40 ( 1.07.20).
19 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUES ALONSO ALFREDO;RODRIGUEZ FORTIS HECTOR. Datos registrales. T 5611, L 2918, F85, S 8, H V 36096, I/A 37 (12.11.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO. Datosregistrales. T 5611, L 2918, F 85, S 8, H V 36096, I/A 38 (12.11.19).
Nombramientos. Apoderado: FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 85, S 8, H V 36096, I/A 39(12.11.19).
05 de Diciembre de 2017Cambio de objeto social. Se ampl铆a el objeto social a: " La realizaci贸n de proyectos, estudios y trabajos medioambientales marinos ylitorales. La prestaci贸n de servicios medioambientales". Datos registrales. T 5611, L 2918, F 84, S 8, H V 36096, I/A 36 (28.11.17).
30 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: LERMA GUISASOLA MARIA DESAMPADOS;GIMENO OLTRA CRISTINA;GUILLEN PARDO CLARA.Datos registrales. T 5611, L 2918, F 27, S 8, H V 36096, I/A 35 (23.10.17).
05 de Julio de 2017Cambio de objeto social. Se ampl铆a el objeto social a: "Ense帽anza no reglada de formaci贸n y perfeccionamiento profesional en todassus modalidades (presencial, a distancia y teleformaci贸n). La realizaci贸n de estudios, an谩lisis, planificaci贸n, programaci贸n,asesoramiento, intervenci贸n, emisi贸n de informes, organizaci贸n,...". Datos registrales. T 5611, L 2918, F 27, S 8, H V 36096, I/A 34(28.06.17).
13 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: BELLIDO BOADA RAMON. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 27, S 8, H V 36096, I/A 33 ( 5.01.17).
28 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: RAMOS APARICI SEVERINO. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 27, S 8, H V 36096, I/A 32(21.04.15).
13 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: SOLERA SOLERA ISIDORO. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 26, S 8, H V 36096, I/A 31 (6.03.15).
25 de Febrero de 2015Revocaciones. Apoderado: ZORRILLA SORIANO FRANCISCO LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MICO JUANJOSE;SANCHEZ MOLINO ENRIQUE;PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE;BELLIDO BOADA RAMON.Datos registrales. T 5611, L 2918, F 25, S 8, H V 36096, I/A 30 (18.02.15).
20 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO;BONET DOMINGO EMILIO. Datos registrales. T 5611, L 2918, F24, S 8, H V 36096, I/A 28 (13.02.15).
Revocaciones. Apoderado: COLOM HERNANDEZ ELIAS. Datos registrales. T 5611, L 2918, F 25, S 8, H V 36096, I/A 29(13.02.15).
06 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO IZQUIERDO JOSE LUIS;ESCUIN MU脩OZ CRISTINA;MARQUES ALONSO ALFREDO.Datos registrales. T 5611, L 2918, F 24, S 8, H V 36096, I/A 27 (29.09.14).
11 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA COMIN DIONISIO. Datos registrales. T 5610, L 2917, F 195, S 8, H V 36096, I/A 26 (4.08.14).
07 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: COLOM HERNANDEZ ELIAS. Datos registrales. T 5610, L 2917, F 195, S 8, H V 36096, I/A 25(24.04.12).
15 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. C/ RONDA DE ISAAC PERAL 4 - (PARQUE TECNOLOGICO) (PATERNA). Datos registrales. T 5610,L 2917, F 195, S 8, H V 36096, I/A 24 ( 6.02.12).