Actos BORME de General De Distribucion Montilla Sl
12 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Presidente: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Consejero: CORDOBAJIMENEZ ANTONIO. Secretario: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Consejero: CORDOBA JIMENEZ ALICIA MARIA. Con.Delegado:CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Consejero: QUINTERO MORALES MARIA DEL ROSARIO. Revocaciones. Apo.Sol.: CORDOBAJIMENEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Presidente: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO.Consejero: CORDOBA JIMENEZ MARIA LUISA. Secretario: CORDOBA JIMENEZ MARIA LUISA. Consejero: CORDOBA JIMENEZALICIA MARIA;CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Cons.Del.Man: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO;CORDOBA JIMENEZ MARIA LUISA.Datos registrales. T 2139 , F 65, S 8, H CO 29040, I/A 13 ( 2.06.23).
25 de Enero de 2016Modificaciones estatutarias. 6.BIS. Otros.-. 13. Funcionamiento Junta Gral.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩ginaweb corporativa: www.generaldistribucionmontilla.com. Datos registrales. T 2136 , F 188, S 8, H CO 29040, I/A 12 (18.01.16).
16 de Marzo de 2015Modificaciones estatutarias. 14. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 2136 , F 188, S 8, H CO 29040, I/A 11 ( 9.03.15).
16 de Febrero de 2015Nombramientos. Consejero: QUINTERO MORALES MARIA DEL ROSARIO. Modificaciones estatutarias. 19. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 2136 , F 187, S 8, H CO 29040, I/A 10 ( 6.02.15).
02 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORDOBA JIMENEZ MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: CORDOBA JIMENEZANTONIO. Presidente: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Consejero: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Secretario: CORDOBAJIMENEZ ANTONIO. Consejero: CORDOBA JIMENEZ ALICIA MARIA. Con.Delegado: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 2136 , F 186, S 8, H CO 29040, I/A 9 (23.01.15).
15 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: MONTES CHACON JOSE LUIS. Datos registrales. T 2136 , F 186, S 8, H CO 29040, I/A 8 ( 8.01.15).
16 de Septiembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 140.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 900.000,00 Euros. Datos registrales. T 2136 , F 185, S 8, HCO 29040, I/A 7 ( 9.09.14).
14 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: CORDOBA JIMENEZ ANTONIO;CORDOBA JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 2136 , F 183, S8, H CO 29040, I/A 6 ( 7.08.14).
06 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 720.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 760.000,00 Euros. Datos registrales. T 2136 , F 180, S 8, HCO 29040, I/A 5 (30.07.14).
05 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ARROYO PEREZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: CORDOBA JIMENEZ MARIA LUISA.Datos registrales. T 2136 , F 180, S 8, H CO 29040, I/A 4 (29.07.14).
07 de Octubre de 2010Revocaciones. Apoderado: HERMOSA ROJAS LAURA. Datos registrales. T 2136 , F 180, S 8, H CO 29040, I/A 3 (29.09.10).
24 de Julio de 2009Cambio de domicilio social. CTRA NACIONAL 331 Km 43,7 - ANTIGUA CARRETERA CORD (MONTILLA). Datos registrales. T2136 , F 179, S 8, H CO 29040, I/A 2 (15.07.09).