Actos BORME de General De Valoraciones Sa
11 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO;JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO;PEREZBENEDI JAVIER. Presidente: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Con.Delegado: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUIPABLO. Datos registrales. T 26164 , F 188, S 8, H M 288243, I/A 16 ( 4.08.23).
24 de Agosto de 2021Cambio de domicilio social. C/ LAMIACO 29 (MADRID). Datos registrales. T 26164 , F 188, S 8, H M 288243, I/A 15 (17.08.21).
27 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JIMENEZ RUIZ-GALVEZ MARIA ALMUDENA. Nombramientos. SecreNoConsj: BLECUALEGAL SLP. Representan: JIMENEZ RUIZ-GALVEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 26164 , F 188, S 8, H M 288243, I/A 14(20.02.20).
16 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: LUQUE VELASCO AUDITORES SL. Datos registrales. T 26164 , F 187, S 8, H M 288243, I/A 13 ( 9.10.19).
29 de Enero de 2019Reelecciones. Consejero: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO;JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO;PEREZBENEDI JAVIER. Presidente: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Con.Delegado: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUIPABLO. Datos registrales. T 26164 , F 187, S 8, H M 288243, I/A 12 (22.01.19).
05 de Abril de 2017Reelecciones. Auditor: LUQUE VELASCO AUDITORES SL. Datos registrales. T 26164 , F 186, S 8, H M 288243, I/A 11 (28.03.17).
17 de Marzo de 2017Cambio de domicilio social. PASEO DE LA ERMITA 9 (MADRID). Datos registrales. T 26164 , F 186, S 8, H M 288243, I/A 10 (8.03.17).
17 de Junio de 2014Reducción de capital. Importe reducción: 207.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 392.400,00 Euros. Datos registrales. T 26164 , F186, S 8, H M 288243, I/A 9 ( 6.06.14).
07 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: JIMENEZ RUIZGALVEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 26164 , F 184, S 8, H M 288243, I/A 6 (30.01.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ASTORQUI MARTINEZ ANGELA CONCEPCION;JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSEALVARO;JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Presidente: ASTORQUI MARTINEZ ANGELA CONCEPCION. Con.Delegado:JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Nombramientos. Auditor: LUQUE VELASCO AUDITORES SL. Consejero: JIMENEZDE ANDRADE ASTORQUI PABLO;JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO;PEREZ BENEDI JAVIER. Presidente: JIMENEZDE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Con.Delegado: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Modificaciones estatutarias. 12.Régimen. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.gevasa.com. Datos registrales. T 26164 , F184, S 8, H M 288243, I/A 7 (30.01.14).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO. Datos registrales. T 26164 , F 185, S 8, H M288243, I/A 8 (30.01.14).
20 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ASTORQUI MARTINEZ ANGELA CONCEPCION. Presidente: ASTORQUI MARTINEZ ANGELACONCEPCION. Consejero: JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO. Con.Delegado: JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSEALVARO. Consejero: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Nombramientos. Consejero: ASTORQUI MARTINEZ ANGELACONCEPCION;JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO;JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Presidente:ASTORQUI MARTINEZ ANGELA CONCEPCION. Con.Delegado: JIMENEZ DE ANDRADE ASTORQUI PABLO. Apoderado: JIMENEZDE ANDRADE BILBAO JOSE ALVARO. Reelecciones. SecreNoConsj: HERRERO TEJEDOR ALGAR CARLOS. Modificacionesestatutarias. Modificación artículo 5º plazo desembolso dividendos pasivos.. Cambio de domicilio social. C/ ARDALES, 3(MADRID). Datos registrales. T 16861 , F 120, S 8, H M 288243, I/A 5 (11.11.09).