Buscador CIF Logo

Actos BORME Genetrix Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Genetrix Sl

Actos BORME Genetrix Sl - B82826546

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Genetrix Sl con CIF B82826546

馃敊 Perfil de Genetrix Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Genetrix Sl

18 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTANA GONZALEZ DOMINGO. Nombramientos. Liquidador: ARRAONA ESTUDIOECONOMICO Y FISCAL SL. Representan: JOSE BUENO TAGUE脩A. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T26748 , F 168, S 8, H M 268899, I/A 55 (11.03.20).

28 de Agosto de 2019
Cambio de domicilio social. C/ CLAUDIO COELLO 52 1潞 (MADRID). Datos registrales. T 26748 , F 168, S 8, H M 268899, I/A 54(21.08.19).

11 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SANTANA GONZALEZ DOMINGO. Nombramientos. Adm. Unico: SANTANA GONZALEZDOMINGO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 26748 , F 168, S 8, H M 268899, I/A 53 ( 4.04.19).

26 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Datos registrales. T 26748 , F 168, S 8, H M 268899,I/A 52 (19.02.19).

29 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO. Datos registrales. T 26748 , F 167, S 8, H M 268899, I/A 51(22.11.18).

27 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA;GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Presidente:GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Consejero: GENIX DE GESTION SL. Con.Delegado: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA.Consejero: SANTANA GONZALEZ DOMINGO. SecreNoConsj: GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO. Representan: ANDUEZARETEGUI JOAQUIN MARIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA;SANTANA GONZALEZDOMINGO. Modificaciones estatutarias. 7. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administradores mancomunados. Datos registrales. T 26748 , F 167, S 8, H M 268899, I/A 50 (19.06.18).

02 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Datos registrales. T 26748 , F 166, S 8, H M 268899, I/A 48(26.01.18).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO. Datos registrales. T 26748 , F 166, S 8, H M 268899, I/A 49(26.01.18).

14 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE LA CALLE PERAL SIXTO. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ-ALMANSA PLAZAANTONIO. Datos registrales. T 26748 , F 166, S 8, H M 268899, I/A 47 ( 4.12.17).

09 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENDOZA SOLANO JUAN LUIS;ECHANIZ URCELAY ALVARO;GONZALEZ MARTINEZEDUARDO;DEL CASTILLO MACHADO PEDRO AGUSTIN;SCHAEFER WERNER FRIEDRICH KNUTH. Nombramientos.Consejero: SANTANA GONZALEZ DOMINGO. Datos registrales. T 26748 , F 166, S 8, H M 268899, I/A 46 (28.01.16).

28 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAPE脩A BOTIJA MARIA LOURDES. Revocaciones. Apoderado: LAPE脩A BOTIJA LOURDES;DELCASTILLO TAMAYO JUAN CARLOS. Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 24 - 4潞 DERECHA (MADRID). Datosregistrales. T 26748 , F 165, S 8, H M 268899, I/A 44 (17.12.15).

Nombramientos. Con.Delegado: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Datos registrales. T 26748 , F 165, S 8, H M 268899, I/A45 (17.12.15).

19 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: LAPE脩A BOTIJA MARIA LOURDES;GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO;GOMEZ-ALMANSA PLAZAANTONIO. Datos registrales. T 26748 , F 165, S 8, H M 268899, I/A 43 (11.05.15).

19 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LA CALLE PERALSIXTO. Datos registrales. T 26748 , F 164, S 8, H M 268899, I/A 42 (11.12.14).

08 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GURA GESTION SL. Representan: ANDUEZA RETEGUI JOAQUIN MARIA. Nombramientos.Consejero: GENIX DE GESTION SL. Representan: ANDUEZA RETEGUI JOAQUIN MARIA. Datos registrales. T 26748 , F 164, S 8,H M 268899, I/A 41 (28.08.14).

30 de Abril de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.- CAMBIADO EL DOMICILIO SOCIAL.. Cambio de domiciliosocial. C/ SANTIAGO GRISOLIA - N潞 2, LOCAL 15 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 26748 , F 163, S 8, H M 268899, I/A 40(22.04.14).

06 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 26748 , F 163, S 8, H M268899, I/A 39 (29.01.14).

16 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. Revocaciones. Apoderado: DE LA HUERTAMARTINEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 26748 , F 161, S 8, H M 268899, I/A 36 ( 8.05.13).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO. Datos registrales. T 26748 , F 161, S 8, H M 268899, I/A 37 (8.05.13).

Nombramientos. Apoderado: DEL CASTILLO TAMAYO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 26748 , F 162, S 8, H M 268899, I/A38 ( 8.05.13).

10 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: ECHANIZ URCELAY ALVARO. Datos registrales. T 26748 , F 159, S 8, H M 268899, I/A 34(29.04.13).

Nombramientos. Consejero: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Presidente: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA.Apoderado: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Datos registrales. T 26748 , F 160, S 8, H M 268899, I/A 35 (29.04.13).

28 de Septiembre de 2011
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . Datos registrales. T 26748 , F159, S 8, H M 268899, I/A 33 (15.09.11).

29 de Junio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 35.646,50 Euros. Resultante Suscrito: 53.474,00 Euros. Datos registrales. T 26748 , F 156, S 8, HM 268899, I/A 32 (16.06.11).

28 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO. Con.Delegado: GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO.Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO. Nombramientos. Presidente: ECHANIZ URCELAY ALVARO.Datos registrales. T 26748 , F 154, S 8, H M 268899, I/A 30 (15.12.10).

Nombramientos. Apoderado: DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. Consejero: DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DELPILAR. Con.Delegado: DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 26748 , F 154, S 8, H M 268899, I/A 31(15.12.10).

09 de Abril de 2010
Nombramientos. Consejero: DEL CASTILLO MACHADO PEDRO AGUSTIN. Datos registrales. T 26748 , F 154, S 8, H M 268899,I/A 29 (26.03.10).

08 de Abril de 2010
Otros conceptos: Subsanada la certificacion incorporada en la escritura que origino la ins.27, en cuanto al apartado sexto, debe decir"septimo" y en el aparto septimo debe decir "octavo".- Datos registrales. T 26748 , F 154, S 8, H M 268899, I/A 28 (26.03.10).

29 de Enero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.800,80 Euros. Resultante Suscrito: 16.887,30 Euros. Datos registrales. T 22366 , F 211, S 8, H M268899, I/A 26 (18.01.10).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 940,20 Euros. Resultante Suscrito: 17.827,50 Euros. Datos registrales. T 26748 , F 153, S 8, H M268899, I/A 27 (18.01.10).

03 de Agosto de 2009
Otros conceptos: SUBSANADA LA ESCRITURA QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 24 EN CUANTO A LA NUMERACION DE LASPARTICIPACIONES QUE ES DEL 120.514 A LA 120.865, AMBAS INCLUSIVE. Datos registrales. T 22366 , F 211, S 8, H M 268899,I/A 25 (22.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n