Actos BORME de Geodis Iberia Sociedad Anonima
30 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MAYOR TONDA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: ECHENAGUSIA LOPEZIGNACIO. Datos registrales. T 25085 , F 217, S 8, H M 451752, I/A 44 (23.11.23).
13 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ INCHAURBE IVAN. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ INCHAURBE IVAN. Datosregistrales. T 25085 , F 215, S 8, H M 451752, I/A 41 ( 2.12.22).
02 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: BARRE GILLAUME MICHEL. Nombramientos. Apoderado: REMOND OLIVIER ROGER ALBERT.Datos registrales. T 25085 , F 213, S 8, H M 451752, I/A 40 (25.11.22).
25 de Octubre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ INCHAURBE IVAN. Datos registrales. T 25085 , F 212, S 8, H M 451752, I/A 39 (18.10.22).
27 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: BERTONNAUD VINCENT. Presidente: BERTONNAUD VINCENT. Consejero: VALICON AMAURYTHIERRY FRANCOIS. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ INCHAURBE IVAN;PARAT LAURENT JEAN GERMAIN. Presidente:SANCHEZ INCHAURBE IVAN. Datos registrales. T 25085 , F 211, S 8, H M 451752, I/A 38 (20.12.21).
26 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CASSAGNE STEPHANE. Secretario: CASSAGNE STEPHANE. Nombramientos. Consejero: BOREERIC MICHEL. SecreNoConsj: MAYOR TONDA FRANCISCO. VsecrNoConsj: USANO BENITEZ DAVID. Datos registrales. T 25085, F 209, S 8, H M 451752, I/A 35 (19.05.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ GARCIA GASPAR ALFONSO;CASSAGNE STEPHANE. Nombramientos. Apoderado: BORE ERICMICHEL. Datos registrales. T 25085 , F 210, S 8, H M 451752, I/A 36 (19.05.21).
Nombramientos. Apoderado: BORE ERIC MICHEL. Datos registrales. T 25085 , F 211, S 8, H M 451752, I/A 37 (19.05.21).
20 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25085 , F 209, S 8, H M 451752,I/A 34 (13.01.20).
14 de Octubre de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: RUIZ GARCIA GASPAR ALFONSO. Presidente: RUIZ GARCIA GASPARALFONSO. Nombramientos. Consejero: BERTONNAUD VINCENT. Presidente: BERTONNAUD VINCENT. Reelecciones.Consejero: CASSAGNE STEPHANE. Secretario: CASSAGNE STEPHANE. Consejero: VALICON AMAURY THIERRY FRANCOIS.Datos registrales. T 25085 , F 207, S 8, H M 451752, I/A 32 ( 7.10.19).
Nombramientos. Apoderado: BARRE GILLAUME MICHEL. Datos registrales. T 25085 , F 207, S 8, H M 451752, I/A 33 ( 7.10.19).
30 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: GOUY ERIC LUCIEN. Nombramientos. Apo.Sol.: CASSAGNE STEPHANE. Datos registrales. T25085 , F 207, S 8, H M 451752, I/A 31 (23.05.18).
09 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GOUY ERIC LUCIEN. Nombramientos. Consejero: VALICON AMAURY THIERRY FRANCOIS.Cambio de domicilio social. AVDA CENTRAL S/N - CENTRO DE CARGA DE BARAJAS (MADRID). Datos registrales. T 25085 , F206, S 8, H M 451752, I/A 30 (27.03.18).
12 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 25085 , F 206, S 8, H M 451752, I/A 29 ( 5.02.18).
27 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCAL GUYARD ALAIN CLAUDE. Revocaciones. Apoderado: PASCAL GUYARD ALAINCLAUDE. Nombramientos. Consejero: GOUY ERIC LUCIEN. Apoderado: GOUY ERIC LUCIEN. Datos registrales. T 25085 , F205, S 8, H M 451752, I/A 28 (20.04.17).
27 de Noviembre de 2015Otros conceptos: Revocados todos los poderes otorgados por la sociedad hasta el 1 de septiembre de 2009, con excepci贸n de lospoderes otorgados a D. Gaspar Alfonso Ruiz Garc铆a mediante los acuerdos adoptados por el consejo de administraci贸n el d铆a 2 deabril de 2009, elevados a escritura p煤blica el 21 de abril de 2009 ante el notario de Madrid D. Segismundo Alvarez Royo-Villanova conel n煤mero 5.393 de su protocolo y que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripci贸n 12& de la hoja de lasociedad; por raz贸n de su fecha queda tambi茅n vigente el otorgado en favor de Don Alain Claude Pascal Guyard objeto de lainscripci贸n 24; y sin perjuicio de los que se inscriban en inscripciones posteriores a la 27&. Datos registrales. T 25085 , F 205, S 8, HM 451752, I/A 27 (20.11.15).
03 de Diciembre de 2014Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 25085 , F 205, S 8, H M 451752, I/A 26 (24.11.14).
11 de Noviembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 800.000,00 Euros. Datos registrales. T 25085 ,F 204, S 8, H M 451752, I/A 25 ( 3.11.14).
12 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DUMAS LAURENT. Revocaciones. Apoderado: DUMAS LAURENT. Nombramientos. Consejero:PASCAL GUYARD ALAIN CLAUDE. Apoderado: PASCAL GUYARD ALAIN CLAUDE. Reelecciones. Consejero: CASSAGNESTEPHANE;RUIZ GARCIA GASPAR ALFONSO. Secretario: CASSAGNE STEPHANE. Presidente: RUIZ GARCIA GASPARALFONSO. Datos registrales. T 25085 , F 203, S 8, H M 451752, I/A 24 ( 5.05.14).
27 de Febrero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.000.000,00 Euros. Desembolsado: 7.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.400.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 8.400.000,00 Euros. Datos registrales. T 25085 , F 202, S 8, H M 451752, I/A 23 (20.02.14).
12 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: DUMAS LAURENT. Datos registrales. T 25085 , F 201, S 8, H M 451752, I/A 21 (31.07.13).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAMPOS CILLEROS SONIA. Apo.Sol.: CAMPOS CILLEROS SONIA. Apo.Manc.: CAMPOSCILLEROS SONIA. Datos registrales. T 25085 , F 202, S 8, H M 451752, I/A 22 ( 1.08.13).
10 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DEMEULENAERE JEAN-LOUIS CHRISTIAN. Presidente: DEMEULENAERE JEAN-LOUISCHRISTIAN. Revocaciones. Apo.Sol.: DEMEULENAERE JEAN-LOUIS CHRISTIAN. Apoderado: DEMEULENAERE JEAN-LOUISCHRISTIAN. Nombramientos. Presidente: RUIZ GARCIA GASPAR ALFONSO. Datos registrales. T 25085 , F 201, S 8, H M451752, I/A 20 ( 2.04.13).
13 de Abril de 2012Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25085 , F 201, S 8, H M 451752, I/A 19 (29.03.12).
22 de Octubre de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.400.000,00 Euros. Otros conceptos:INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SIN VARIAR LACIFRA DEL CAPITAL Y REDUCIENDO EL NUMERO DEACCIONES QUE LOREPRESENTAN. Datos registrales. T 25085 , F 200, S 8, H M 451752, I/A 18 (11.10.10).
19 de Agosto de 2010Ampliacion del objeto social. ADQUISICION GESTION ARRIENDO EXPLOTACION Y VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS.Datos registrales. T 25085 , F 199, S 8, H M 451752, I/A 17 ( 9.08.10).
30 de Noviembre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.286.437,82 Euros. Resultante Suscrito: 4.000.000,00 Euros. Datos registrales. T25085 , F 198, S 8, H M 451752, I/A 16 (18.11.09).
22 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: DEMEULENAERE JEAN-LOUIS CHRISTIAN. Datos registrales. T 25085 , F 198, S 8, H M 451752,I/A 15 (10.07.09).
18 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: GEODIS LOGISTICS SOCIETE ANONYME;TRANSPORT GESTION ET PARTICIPATIONS SOCIETELIMITE;DEPRAETER JEAN MICHEL LOUIS. Presidente: DEPRAETER JEAN MICHEL LOUIS. Consejero: GEODIS SOCIETEANONYME. SecreNoConsj: CASSAGNE STEPHANE. Revocaciones. Apoderado: TORRES TORRES ANTONIO;MONTONCONDON VALERIO;FERNANDEZ ADEVA FRANCISCO JAVIER;TORRES TORRES ANTONIO;MONTON CONDONVALERIO;FLORES GORDILLO JUAN MIGUEL;ARANDIA BENGOECHEA JESUS MARIA;GALAN CARDENAS MIGUEL;DE ANDRESMATA RAFAEL. Apo.Manc.: BERNABE GALLEGO ANTONIO;CASLA BARRIO MIGUEL. Apoderado: COROMINAS GUIU MANUEL.Apo.Manc.: COROMINAS GUIU MANUEL. Apoderado: MARTOS SERRANO JUAN;OYARZUN PEREZ JUAN CARLOS.Nombramientos. Consejero: DEMEULENAERE JEAN-LOUIS CHRISTIAN;CASSAGNE STEPHANE;DUMAS LAURENT;RUIZGARCIA GASPAR ALFONSO. Presidente: DEMEULENAERE JEAN-LOUIS CHRISTIAN. Secretario: CASSAGNE STEPHANE. Otrosconceptos: Han CESADO como REPRESENTANTES personas f铆sicas DON ALAIN PICARD, DON STEPHANE CASSAGNE y DONGEOFFROY HENRY DE VILLENEUVE con fecha 1 de Abril de 2009.- Datos registrales. T 25085 , F 191, S 8, H M 451752, I/A 10 (5.06.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: DEMEULENAERE JEAN-LOUIS CHRISTIAN. Datos registrales. T 25085 , F 193, S 8, H M 451752, I/A11 ( 5.06.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ GARCIA GASPAR ALFONSO. Datos registrales. T 25085 , F 194, S 8, H M 451752, I/A 12 (5.06.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ GARCIA GASPAR ALFONSO;CAMPOS CILLEROS SONIA. Datos registrales. T 25085 , F 197,S 8, H M 451752, I/A 14 ( 5.06.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPOS CILLEROS SONIA. Datos registrales. T 25085 , F 195, S 8, H M 451752, I/A 13 ( 5.06.09).
20 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 12.999.997,56 Euros. Desembolsado: 12.999.997,56 Euros. Resultante Suscrito: 20.286.437,82Euros. Resultante Desembolsado: 20.286.437,82 Euros. Datos registrales. T 25085 , F 190, S 8, H M 451752, I/A 9 ( 8.01.09).
05 de Enero de 2009Revocaciones. Apoderado: PEREZ COSMEN FRANCISCO JAVIER;GARCIA SANCHEZ JUAN JOSE;RUIZ LOPEZ RANCA脩OPEDRO MIGUEL;GONZALEZ DE LOS RIOS ALBERTO;CANTERO YUSTA ALBERTO. Datos registrales. T 25085 , F 189, S 8, H M451752, I/A 8 (16.12.08).